TRIPACK SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRIPACK SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC215872
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    • Activités d'emballage (82920) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 7 Halbeath Interchange Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que secrétaire le 31 mai 2023

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Norman Robert Scott en tant que directeur le 31 mai 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan Graham Milne en tant qu'administrateur le 31 mai 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tracy Jayne Trotter en tant que directeur le 02 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Gibson en tant que directeur le 02 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MILNE, Alan Graham
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Administrateur
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    ScotlandBritish230205760001
    NEWLANDS, Moira
    4 Carrongrange Gardens
    Stenhousemuir
    FK5 3DU Larbert
    Secrétaire
    4 Carrongrange Gardens
    Stenhousemuir
    FK5 3DU Larbert
    British92849010001
    SCOTT, Norman Robert
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Secrétaire
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    British134405100001
    VOSILIUS, William
    19 Douglas Gardens
    G71 7HB Uddingston
    Lanarkshire
    Secrétaire
    19 Douglas Gardens
    G71 7HB Uddingston
    Lanarkshire
    British122440260001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALEXANDER, Scott
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Administrateur
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    ScotlandBritish149863960001
    GIBSON, Alan
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Administrateur
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    ScotlandBritish94552630001
    HALLIDAY, George Macleod
    Oakleigh
    The Ross
    PH6 2JRB Comrie
    Administrateur
    Oakleigh
    The Ross
    PH6 2JRB Comrie
    British77037140002
    LAWLOR, Mark
    1 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    Administrateur
    1 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    United KingdomBritish74376620001
    PATERSON, William
    296 Glasgow Road
    Eaglesham
    G76 0EW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    296 Glasgow Road
    Eaglesham
    G76 0EW Glasgow
    Lanarkshire
    British558550002
    SCOTT, John Carruthers
    Glen Alba House
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Glen Alba House
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Auchterarder
    Perthshire
    UkBritish142251800001
    SCOTT, Norman Robert
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Administrateur
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    ScotlandBritish134405100001
    TROTTER, Tracy Jayne
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    Administrateur
    Business Park
    Kingseat Road, Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    Unit 7 Halbeath Interchange
    Fife
    ScotlandBritish103585250002
    VOSILIUS, William
    19 Douglas Gardens
    G71 7HB Uddingston
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Douglas Gardens
    G71 7HB Uddingston
    Lanarkshire
    ScotlandBritish122440260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRIPACK SOLUTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scott Timber Limited
    Halbeath Interchange Business Park, Kingseat Road
    Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    U7
    Scotland
    03 janv. 2017
    Halbeath Interchange Business Park, Kingseat Road
    Halbeath
    KY11 8RY Dunfermline
    U7
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc105196
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TRIPACK SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 20 oct. 2009
    Livré le 02 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 02 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 nov. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 09 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 07 juin 2006
    Livré le 16 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 16 juin 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juil. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 juil. 2001
    Livré le 09 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juil. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 05 avr. 2001
    Livré le 07 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a factoring agreement dated 6 april 2001
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Scotland Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0