KEILLER (CENTRAL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEILLER (CENTRAL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC217208
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    28 Stafford Street
    Edinburgh
    EH3 7BD Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JAMES KEILLER (CENTRAL) LIMITED 18 juin 200118 juin 2001
    JAMES KEILLER (BONAR) LIMITED23 mars 200123 mars 2001

    Quels sont les derniers comptes de KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2004

    11 pagesAA

    Statuts

    6 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2003

    11 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Certificat de changement de nom

    Company name changed james keiller (central) LIMITED\certificate issued on 11/02/04
    2 pagesCERTNM

    Qui sont les dirigeants de KEILLER (CENTRAL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEWART, Ian Baillie
    7 Rosamunde Pilcher Drive
    Longforgan
    DD2 5EF Dundee
    Secrétaire
    7 Rosamunde Pilcher Drive
    Longforgan
    DD2 5EF Dundee
    British95318310001
    GEDDES, Crawford Brown
    34 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    Administrateur
    34 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    ScotlandBritish81109150001
    LINTON, Bruce Reid
    2a Ellieslea Road
    West Ferry
    DD5 1JG Dundee
    Angus
    Administrateur
    2a Ellieslea Road
    West Ferry
    DD5 1JG Dundee
    Angus
    ScotlandBritish72090180001
    THOMSON, William George Ritchie
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    Administrateur
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    ScotlandBritish72331280002
    TODD, Eleanor Elizabeth
    Blacketyside Farm
    KY8 5PX Leven
    Fife
    Secrétaire
    Blacketyside Farm
    KY8 5PX Leven
    Fife
    British48236670002
    DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Secrétaire
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    137092310001
    DAVIDSON CHALMERS (NOMINEES) LIMITED
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Midlothian
    900016870001

    KEILLER (CENTRAL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 08 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 janv. 2003
    Livré le 31 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 dunswood road, ward park industrial estate, cumbernauld--title number DMB657.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 déc. 2002
    Livré le 08 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 drovers road, east mains industrial estate, broxburn.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juil. 2002
    Livré le 25 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Block 31, dunsinane avenue, dunsinane industrial estate, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juil. 2002
    Livré le 15 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Block 5, bellshill industrial estate, bellshill.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 mars 2002
    Livré le 02 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 bain square, kirkton campus, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 3, bankhead avenue, bankhead industrial estate, glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • The Fife Council
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 2001
    Livré le 16 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 3, bankhead avenue, bankhead industrial estate, glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 19 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 1 dunlop square, deans southwest industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 19 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 6 nairn road, deans industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 12 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 dunlop square, deans industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 12 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Industrial unit at 6 nairn road, deans industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 12 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land & buildings at 36 firth road, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0