TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC217363
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bishop's Court
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    5 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Weatherford Centre Souterhead Road Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LF à Bishop's Court 29 Albyn Place Aberdeen AB10 1YL le 05 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2016

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 avr. 2016

    État du capital au 13 avr. 2016

    • Capital: GBP 263
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Julie Mary Thonson le 10 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Richard Khalil Strachan en tant que secrétaire le 09 oct. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gemma Rose-Garvie en tant que secrétaire le 09 oct. 2015

    1 pagesTM02

    État du capital après une attribution d'actions au 31 août 2015

    • Capital: GBP 263.00
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Restriction on share cap revoked 31/08/2015
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Anthony Timmins en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mars 2015

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 163
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2014

    État du capital au 02 avr. 2014

    • Capital: GBP 163
    SH01

    Nomination de Mr Neil Alexander Macleod en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    18 pagesAA

    Nomination de Ms Julie Mary Thonson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian Moncur en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Gemma Rose-Garvie en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STRACHAN, Richard Khalil
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    Secrétaire
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    201977060001
    MACLEOD, Neil Alexander
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    Administrateur
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    ScotlandBritish177581770001
    PRENTICE, Euan Robertson
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Administrateur
    Souter Head Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    ScotlandBritish168927430001
    THOMSON, Julie Mary
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    Administrateur
    29 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Bishop's Court
    ScotlandBritish171856740001
    CAMPBELL, Sandra
    38 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    38 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Inverness Shire
    British1214430004
    FULTON, William Gray
    36 Brimmond Drive
    AB32 6SZ Westhill
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    36 Brimmond Drive
    AB32 6SZ Westhill
    Aberdeenshire
    British146737450001
    JAMIESON, Alison Margaret
    54 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Secrétaire
    54 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    British75084150002
    MONCUR, Brian
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Secrétaire
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    146422740001
    ROSE-GARVIE, Gemma
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Secrétaire
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    172789160001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CAMPBELL, Sandra
    38 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    38 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Inverness Shire
    British1214430004
    FRASER, Iain
    44 East Park Road
    AB51 0FE Kintore
    Aberdeen
    Administrateur
    44 East Park Road
    AB51 0FE Kintore
    Aberdeen
    ScotlandBritish45223920001
    FULTON, William Gray
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Administrateur
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    United KingdomBritish153399240001
    HENRY, Joseph Claude
    Pin Oak Lane
    77401 Bellaire
    4528
    Texas
    United States
    Administrateur
    Pin Oak Lane
    77401 Bellaire
    4528
    Texas
    United States
    UsaUnited States139598660001
    JAMIESON, Angus Lamberton, Professor
    54 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Highland
    Administrateur
    54 Crown Drive
    IV2 3QG Inverness
    Highland
    United KingdomBritish86870690001
    LOCK, Geoffrey Hampton
    Bynach
    Inchmarlo
    AB31 4BS Banchory
    Administrateur
    Bynach
    Inchmarlo
    AB31 4BS Banchory
    United KingdomBritish90938900001
    MARTIN, Burt Michael
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    Administrateur
    4817 Welford
    77401 Bellaire
    Texas
    United States74615750001
    MILLS, Douglas Mark
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    Carlton House
    United Kingdom
    Administrateur
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    Carlton House
    United Kingdom
    United KingdomUnited States136772140001
    MONCUR, Brian
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Administrateur
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    United KingdomBritish118915490001
    NELSON, Alan Andrew
    5 Crown Drive
    IV2 3NJ Inverness
    Administrateur
    5 Crown Drive
    IV2 3NJ Inverness
    ScotlandBritish62626190001
    SOUTHREN, Thomas Charles, Dr
    31 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    31 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    British116683810001
    TIMMINS, Paul Anthony
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    Administrateur
    Souterhead Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LF Aberdeen
    Weatherford Centre
    Scotland
    UsaBritish130810230001

    TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 17 oct. 2006
    Livré le 04 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 mars 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the invoice discounting agreement dated 17 march 2006
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juin 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 11 juin 2004
    Livré le 18 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juin 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 05 juin 2004
    Livré le 17 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2016Commencement of winding up
    23 juil. 2018Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0