TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC217363 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Bishop's Court 29 Albyn Place AB10 1YL Aberdeen |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 5 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Weatherford Centre Souterhead Road Altens Industrial Estate Aberdeen AB12 3LF à Bishop's Court 29 Albyn Place Aberdeen AB10 1YL le 05 oct. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Julie Mary Thonson le 10 déc. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Khalil Strachan en tant que secrétaire le 09 oct. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gemma Rose-Garvie en tant que secrétaire le 09 oct. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 31 août 2015
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 16 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Timmins en tant que directeur le 30 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Neil Alexander Macleod en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Julie Mary Thonson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Moncur en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Gemma Rose-Garvie en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRACHAN, Richard Khalil | Secrétaire | 29 Albyn Place AB10 1YL Aberdeen Bishop's Court | 201977060001 | |||||||
| MACLEOD, Neil Alexander | Administrateur | 29 Albyn Place AB10 1YL Aberdeen Bishop's Court | Scotland | British | 177581770001 | |||||
| PRENTICE, Euan Robertson | Administrateur | Souter Head Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | Scotland | British | 168927430001 | |||||
| THOMSON, Julie Mary | Administrateur | 29 Albyn Place AB10 1YL Aberdeen Bishop's Court | Scotland | British | 171856740001 | |||||
| CAMPBELL, Sandra | Secrétaire | 38 Crown Drive IV2 3QG Inverness Inverness Shire | British | 1214430004 | ||||||
| FULTON, William Gray | Secrétaire | 36 Brimmond Drive AB32 6SZ Westhill Aberdeenshire | British | 146737450001 | ||||||
| JAMIESON, Alison Margaret | Secrétaire | 54 Crown Drive IV2 3QG Inverness | British | 75084150002 | ||||||
| MONCUR, Brian | Secrétaire | Souterhead Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | 146422740001 | |||||||
| ROSE-GARVIE, Gemma | Secrétaire | Souterhead Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | 172789160001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| CAMPBELL, Sandra | Administrateur | 38 Crown Drive IV2 3QG Inverness Inverness Shire | British | 1214430004 | ||||||
| FRASER, Iain | Administrateur | 44 East Park Road AB51 0FE Kintore Aberdeen | Scotland | British | 45223920001 | |||||
| FULTON, William Gray | Administrateur | Souterhead Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | United Kingdom | British | 153399240001 | |||||
| HENRY, Joseph Claude | Administrateur | Pin Oak Lane 77401 Bellaire 4528 Texas United States | Usa | United States | 139598660001 | |||||
| JAMIESON, Angus Lamberton, Professor | Administrateur | 54 Crown Drive IV2 3QG Inverness Highland | United Kingdom | British | 86870690001 | |||||
| LOCK, Geoffrey Hampton | Administrateur | Bynach Inchmarlo AB31 4BS Banchory | United Kingdom | British | 90938900001 | |||||
| MARTIN, Burt Michael | Administrateur | 4817 Welford 77401 Bellaire Texas | United States | 74615750001 | ||||||
| MILLS, Douglas Mark | Administrateur | 33 Robert Adam Street W1U 3HR London Carlton House United Kingdom | United Kingdom | United States | 136772140001 | |||||
| MONCUR, Brian | Administrateur | Souterhead Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | United Kingdom | British | 118915490001 | |||||
| NELSON, Alan Andrew | Administrateur | 5 Crown Drive IV2 3NJ Inverness | Scotland | British | 62626190001 | |||||
| SOUTHREN, Thomas Charles, Dr | Administrateur | 31 Midmills Road IV2 3NZ Inverness Inverness Shire | British | 116683810001 | ||||||
| TIMMINS, Paul Anthony | Administrateur | Souterhead Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | Usa | British | 130810230001 |
TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Créé le 17 oct. 2006 Livré le 04 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 mars 2006 Livré le 06 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the invoice discounting agreement dated 17 march 2006 | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 11 juin 2004 Livré le 18 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 05 juin 2004 Livré le 17 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TECH 21 ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0