SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOLSTAD CABLE (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC217939
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FOODSHARE LIMITED09 avr. 200109 avr. 2001

    Quels sont les derniers comptes de SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    23 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 09 avr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    23 pagesAA

    Inscription de la charge SC2179390011, créée le 12 oct. 2020

    24 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2179390012, créée le 12 oct. 2020

    36 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2179390013, créée le 12 oct. 2020

    44 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2179390014, créée le 12 oct. 2020

    69 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2179390010, créée le 12 oct. 2020

    21 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2179390009, créée le 12 oct. 2020

    20 pagesMR01

    Statuts

    14 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 09 avr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Roger Wilman le 08 avr. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Roger Wilman le 08 avr. 2020

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Ledingham Chalmers Llp en tant que secrétaire le 08 nov. 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Lc Secretaries Limited en tant que secrétaire le 08 nov. 2019

    2 pagesAP04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LC SECRETARIES LIMITED
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Secrétaire
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC299827
    112802860001
    DALE, Graham Alexander
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    United KingdomBritishDirector139488940002
    WILMAN, Roger
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Administrateur
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector49072100011
    NEWBERRY, Clare
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    Secrétaire
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    BritishSolicitor79423480001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    112938080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ALLAN, Keith Kellas Armstrong
    3 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    3 Riverside
    Blackhall
    AB31 6PS Banchory
    Kincardineshire
    ScotlandBritishCompany Director65176130001
    EIKESDAL, Harald Magne
    Strandgt 94
    Haugesund
    Norway
    Administrateur
    Strandgt 94
    Haugesund
    Norway
    NorwegianSolicitor78079660001
    KJAERSTAD, Helle
    9 Fox Hill Court
    Sussex Road
    RH16 4EB Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    9 Fox Hill Court
    Sussex Road
    RH16 4EB Haywards Heath
    West Sussex
    NorwegianTrainee Solicitor75991830001
    LÜHR OLSEN, Lars
    Gjerdegata
    6065 Ulsteinvik
    40
    Møre Og Romsdal
    Norway
    Administrateur
    Gjerdegata
    6065 Ulsteinvik
    40
    Møre Og Romsdal
    Norway
    NorwayNorwegianDeputy Managing Director, Ulstein Shipping As198225850001
    NEWBERRY, Clare
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    Administrateur
    28 Saint Anns Villas
    W11 4RS London
    BritishSolicitor79423480001
    SOLSTAD, Ellen
    53 Albury Mansions
    AB11 6TJ Aberdeen
    Administrateur
    53 Albury Mansions
    AB11 6TJ Aberdeen
    NorwegianGeneral Manager76488220001
    STAKKESTAD, Sven
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    Administrateur
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    NorwayNorwegianCompany Director62575140001
    ULSTEIN, Gunvor
    6065 Ulsteinvik
    Onglasaetra 48
    Norway
    Administrateur
    6065 Ulsteinvik
    Onglasaetra 48
    Norway
    NorwegianCompany Director76280630002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScotland
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc091332
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SOLSTAD CABLE (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 15 oct. 2020
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 15 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 15 oct. 2020
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 15 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 15 oct. 2020
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 15 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 15 oct. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 15 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 14 oct. 2020
    En cours
    Brève description
    All accounts referred to in recital (b) of the account security deed dated 12 october 2020.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 14 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2020
    Livré le 14 oct. 2020
    En cours
    Brève description
    M.V. normand clipper with imo number 9236200.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 14 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of general assignment
    Créé le 26 avr. 2005
    Livré le 17 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent of the company into, to and under: (a) the time charter guarantee dated 22 april 2005 made between clough limited and the company in relation to clough regional pty ltds obligations under (b) the time charterparty dated as of 22 april 2005 made between the company and clough regional pty LTD and all claims, rights and remedies of the company arising therefrom.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of general assignment
    Créé le 12 mai 2004
    Livré le 19 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interest of the company in, to and under the time charter.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 19 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of general assignment (no.2)
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the right, title, benefit and interest, present and future, actual or contingent of the company in, to and under (a) the new tyco guarantee and (b) the assigned and assumed time charter and the time charter assignment and assumption agreement, and all claimes, rights and remedies of the company arising therefrom.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of general assignment (no.2)
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the right, title, benefit and interest, present and future, actual or contingent of the company in, and to and under (a) the new tyco guarantee and (b) the assigned and assumed time charter and the time charter assignment and assumption agreement, and all claims, rights and remedies of the company.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Security deed of assignment
    Créé le 21 juin 2001
    Livré le 04 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The sums and liabilities which are or may become payable or owing pursuant to the deposit agreement
    Brèves mentions
    All of the present and future rights, title, benefit and interest of the company in and to the deposit, the account and the deposit agreement.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of general assignment
    Créé le 20 juin 2001
    Livré le 27 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest, present and future, actual or contingent of the company in, to and under (a) the tycom agreement, (b)the time charter, (c) the insurances and (d) any requisition compensation and al claims, rights and remedies of the company arising therefrom (including all damages and compensation payable for or in respect thereof) all the defined terms as defined in the assignment.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 27 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Security deed of assignment
    Créé le 05 juin 2001
    Livré le 20 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the present and future rights, title, benefit and interest of the company in and to the deposit, the account and the deposit agreement.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 20 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of general assignment
    Créé le 30 mai 2001
    Livré le 04 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All of the right title and interest present and future actual or contingent of the company in to and under (a) the tycom gurantee (b)the time charter, (c) the insurances and (d) any requisition compensation and all claims rights and remedies of the company arising therefrom (including all damages and compensation payable for or in repsect thereof) all as the defined terms as defined in the assignment.
    Personnes ayant droit
    • Solstad Rederi As
    Transactions
    • 04 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0