PACIFIC SHELF 1047 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPACIFIC SHELF 1047 LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC220011
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2007
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2008
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au08 juin 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation22 juin 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Iain James Blakeley en tant que directeur le 03 nov. 2023

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages287

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis du rapport du séquestre

    18 pages3.5(Scot)

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    2 pages1(Scot)

    Avis du rapport du séquestre

    18 pages3.5(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    3 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    15 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de PACIFIC SHELF 1047 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHARON, Robert Danny
    Westerings
    City
    HP14 4AB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Westerings
    City
    HP14 4AB Bledlow Ridge
    Buckinghamshire
    British93514800001
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secrétaire
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    MCCLUSKEY, Brian
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    Secrétaire
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    British96335270001
    MCCRORY, David Andrew
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    British82928480001
    O'HARA, William Clive
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    British73042150001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BESLEY, Ian Philip Andrew
    52a Warrington Crescent
    W9 London
    Administrateur
    52a Warrington Crescent
    W9 London
    United KingdomBritish5677140001
    BLAKELEY, Iain James
    Shenley Hill
    WD7 7BD Radlett
    58
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Shenley Hill
    WD7 7BD Radlett
    58
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135106330001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Danmure
    Western Avenue
    PH3 1IJ Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Danmure
    Western Avenue
    PH3 1IJ Auchterarder
    Perthshire
    British75114520001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    HANCOCK, Christopher
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Administrateur
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    EnglandBritish87069290001
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Administrateur
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Administrateur
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCRORY, David Andrew
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    64 Terregles Avenue
    G41 4LX Glasgow
    Lanarkshire
    British82928480001
    MCMAHON, James Cairns
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    Greenacres
    Kerrix Road
    KA1 5QP Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritish159708270001
    O'HARA, William Clive
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    9 Eglinton Drive
    G46 7NQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish73042150001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    PACIFIC SHELF 1047 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 04 mai 2004
    Livré le 07 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    81 & 83 king street, 2 water lane & 36 sandbeg street, kilmarnock AYR38856.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 04 mai 2004
    Livré le 07 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    135/137 high street, perth PTH10462.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 08 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all estates or interests in the freehold and leasehold property; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juin 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 21 avr. 2004
    Livré le 08 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 41, 43 and 45 midland road, bedford (title number BD140132), 83 broadmead, bristol (title number AV97321) & 54 other properties - see mortgage document for full details - ; fixed and floating charges over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 10 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    135-137 high street, perth.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited as Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 10 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 07 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    81-83 king street and 2 water lane, kilmarnock--title number ayr 38856.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of assignment
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 14 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the rights, titles, benefits and interests of the company to the rents over the property known as angel shopping development, crewe (see mortgage document for full list of properties).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 14 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 14 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charge over all moneys from time to time deposited with the trustee; floating charge over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 14 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 mai 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 03 janv. 2009Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
      • Numéro de dossier 1
      • Numéro de dossier 2
    Assignation of rents
    Créé le 25 mars 2003
    Livré le 26 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    135-137 high street, perth.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 26 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 25 mars 2003
    Livré le 26 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    81-83 king street and 2 walter lane, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 26 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 janv. 2002
    Livré le 28 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property (18 above bar, southampton), fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 sept. 2001
    Livré le 28 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    135 & 137 high street, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 sept. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 sept. 2001
    Livré le 28 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    81/83 king street and 2 water lane, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 sept. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    PACIFIC SHELF 1047 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    London
    administrative receiver
    55 Baker Street
    London
    Toby Scott Underwood
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    administrative receiver
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Bernard Stephen
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    administrative receiver
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Notesscottish-insolvency-info
    2Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    London
    administrative receiver
    55 Baker Street
    London
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    administrative receiver
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    James Bernard Stephen
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    administrative receiver
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0