ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED

ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC220087
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    47 Melville Street
    EH3 7HL Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Logue en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Awg Property Director Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Iain Logue le 03 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TULLY, Robert Charles
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish48389830002
    AWG PROPERTY DIRECTOR LIMITED
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Administrateur
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5341812
    148490000001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011040001
    BENNETT, Gordon
    25a Roseberry Court
    Dowanhill
    G12 9LB Glasgow
    Administrateur
    25a Roseberry Court
    Dowanhill
    G12 9LB Glasgow
    ScotlandBritish59203870001
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish66174560001
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    KENNEDY, David Samuel
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    Administrateur
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    British93176930001
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Administrateur
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    British61660001
    LOGUE, David Iain
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    Administrateur
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    United KingdomBritish91223970002
    MACKAY, Ewan William
    3 Neuk Avenue
    Muirhead
    G69 9EX Glasgow
    Administrateur
    3 Neuk Avenue
    Muirhead
    G69 9EX Glasgow
    ScotlandBritish64627230005
    MACKIE, Carole
    Laigh Kittochside Cottage
    Kittochside Clarkston
    G76 9ET Glasgow
    Administrateur
    Laigh Kittochside Cottage
    Kittochside Clarkston
    G76 9ET Glasgow
    British43649780001
    POPLE, David George
    16 St Crispin's Road
    Newtonhill
    AB39 3PS Stonehaven
    Aberdeenshire
    Administrateur
    16 St Crispin's Road
    Newtonhill
    AB39 3PS Stonehaven
    Aberdeenshire
    British53727020005
    QUEENSFERRY FORMATIONS LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011030001
    QUEENSFERRY REGISTRATIONS LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011020001

    ABBEY MORRISON (MCPHATER STREET) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 09 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The triangular shaped area of ground bounded by cowcaddens road, mcphater street and port dundas road, glasgow within the county of lanark extending to 5,330 square metres.
    Personnes ayant droit
    • Abbey Projects Limited
    Transactions
    • 09 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Triangular shaped piece of ground bounded by cowcaddens road, mcphater street and port dundas road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 28 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Triangular shaped area of ground bounded by cowcaddens road, mcphater street and port dundas road, glasgow---title number GLA160639.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 mars 2002
    Livré le 20 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mars 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 18 juil. 2001
    Livré le 01 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morrison Homes Limited
    Transactions
    • 01 août 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0