REACTEC LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REACTEC LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC221428 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REACTEC LIMITED ?
| Adresse du siège social | 103 Level 1 Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REACTEC LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REACTEC LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 03 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 20 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour REACTEC LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Charles Dorks le 04 sept. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Emma Jane Hayes le 04 sept. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Notification de Ideagen Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 août 2025 | 2 pages | PSC02 | ||
Nomination de Mr Stephen Thompson en tant que secrétaire le 13 août 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Toby William Driver en tant qu'administrateur le 13 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jacqueline Mclaughlin en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Emma Jane Hayes en tant qu'administrateur le 13 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Benjamin Charles Dorks en tant qu'administrateur le 13 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Samuel Robin Thomas en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Iain Ruaraidh Mackay en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alastair James Hogg en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Eleanor Claire Barnard en tant que secrétaire le 13 août 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Leif Crombie Anderson en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Eleanor Claire Barnard en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Paul Buckingham en tant que directeur le 13 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 13 août 2025 | 2 pages | PSC09 | ||
Changement d'adresse du siège social de Vantage Point 3 Cultins Road Edinburgh EH11 4DF à 103 Level 1 Strathmore House East Kilbride Glasgow G74 1LF le 13 août 2025 | 1 pages | AD01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 13 août 2025
| 3 pages | SH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2025 avec mises à jour | 11 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge SC2214280005 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 20 pages | AA | ||
Nomination de Mr Leif Crombie Anderson en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Samuel Robin Thomas en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2024 avec mises à jour | 11 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Eleanor Claire Barnard le 01 août 2024 | 1 pages | CH03 | ||
Qui sont les dirigeants de REACTEC LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMPSON, Stephen | Secrétaire | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | 339123720001 | |||||||
| DORKS, Benjamin Charles | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | England | British | 224413540007 | |||||
| DRIVER, Toby William | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | England | British | 337817630001 | |||||
| HAYES, Emma Jane | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | England | British | 271446630002 | |||||
| BARNARD, Eleanor Claire | Secrétaire | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | British | 66958040003 | ||||||
| ROBSON, Fiona Jane | Secrétaire | 16 Whitecraig Avenue EH21 8PE Whitecraig Musselburgh | British | 77208080001 | ||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh | 42680350001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| ADCOCK, Roger Brian | Administrateur | Peter Avenue RH8 9LG Oxted 20 Surrey United Kingdom | England | British | 8738440001 | |||||
| ANDERSON, Leif Crombie | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | Scotland | British | 284339590001 | |||||
| BARNARD, Eleanor Claire | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | Scotland | British | 204342360001 | |||||
| BUCKINGHAM, Mark Paul | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | Scotland | British | 82378840001 | |||||
| GORMAN, Tracey | Administrateur | 3 Cultins Road EH11 4DF Edinburgh Vantage Point | England | British | 207184250001 | |||||
| HOGG, Alastair James | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | Scotland | British | 264549840001 | |||||
| KENT, Timothy | Administrateur | (1f) Royal Circus EH3 6TL Edinburgh 11 United Kingdom | Scotland | British | 82698590002 | |||||
| MACKAY, Iain Ruaraidh | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | United Kingdom | British | 82921070001 | |||||
| MCCANN, Janice | Administrateur | 3 Cultins Road EH11 4DF Edinburgh Vantage Point | Scotland | British | 45536640001 | |||||
| MCGOFF, Andrew Peter | Administrateur | Galachlaw Shot EH10 7JF Edinburgh 11 | Scotland | British | 134370820001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Jacqueline | Administrateur | 3 Cultins Road EH11 4DF Edinburgh Vantage Point | United Kingdom | British | 187784930001 | |||||
| MCNAIR, Ian Spence | Administrateur | 13 Middlepenny Place PA14 6XD Langbank Renfrewshire | Scotland | British | 116922000001 | |||||
| MCSWAN, Malcolm | Administrateur | Latch House Abernyte PH14 9SU Perth Perthshire | Scotland | British | 108155240001 | |||||
| O'HAGAN, James | Administrateur | 3 Cultins Road EH11 4DF Edinburgh Vantage Point Scotland | United Kingdom | British | 107170004 | |||||
| PERRIN, Fiona Joanne | Administrateur | 3 Cultins Road EH11 4DF Edinburgh Vantage Point | England | British | 241775990001 | |||||
| RAE, Robin Bell | Administrateur | St Michaels Inveresk EH21 7UA Musselburgh East Lothian | United Kingdom | British | 82543520001 | |||||
| RUTTERFORD, Michael David | Administrateur | c/o Rutterford Ltd Rutland Square EH1 2BB Edinburgh 20 Scotland | Scotland | British | 168210050001 | |||||
| RUTTERFORD, Michael David | Administrateur | Flat 14 22-14 Kinellan Road EH12 6ES Murrayfield Midlothian | Scotland | British | 168210050001 | |||||
| SWEENEY, Charles | Administrateur | 9 Williamwood Park West Netherlee G44 3TE Glasgow Scotland | Scotland | British | 58158990002 | |||||
| THOMAS, Samuel Robin | Administrateur | Strathmore House East Kilbride G74 1LF Glasgow 103 Level 1 Scotland | England | British | 328091050001 | |||||
| WADDELL, John Maclaren Ogilvie | Administrateur | 16 Kinghorn Place EH6 4BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 113233140001 | |||||
| WATSON, Peter | Administrateur | 3 4f1 Bruntsfield Place EH10 4HN Edinburgh Midlothian | British | 77888420002 | ||||||
| WINTON, Keith David Roy, Dr | Administrateur | 6 Greenbank Row EH10 5SY Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 233150001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REACTEC LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideagen Limited | 13 août 2025 | Ruddington Fields Business Park Ruddington NG11 6JS Nottingham One Mere Way England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour REACTEC LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 03 août 2017 | 13 août 2025 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
| 20 juil. 2016 | 01 août 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0