SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC222340 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 8 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ Scotland à C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD le 19 mai 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Charles Mccabe en tant que directeur le 15 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Charles Mccabe en tant que directeur le 15 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jeremy John Tutton en tant qu'administrateur le 01 août 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Esplanade Director Limited en tant que directeur le 26 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 9 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 15 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 17 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 14 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland à C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ le 01 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 26 nov. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 26 nov. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2019 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU à C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 04 juil. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2018 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin Charles Mccabe en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430250001 | ||||||||||
MCCABE, Scott Richard | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Managing Director | 151895310001 | ||||||||
TUTTON, Jeremy John | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | United Kingdom | British | Financial Controller | 113787520002 | ||||||||
BROOK, Susan Margaret | Secrétaire | 16 Bradley Lane Rufforth YO23 3QJ York North Yorkshire | British | 72328070001 | ||||||||||
BROWN, Stewart David | Secrétaire | 6 Moat Place EH14 1NY Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 77509780001 | |||||||||
MCBRIDE, Stephen Paul | Secrétaire | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||||||
BLAIN, Andrew John | Administrateur | 60 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | Scotland | British | Solicitor | 40585290002 | ||||||||
BROWN, Stewart David | Administrateur | 6 Moat Place EH14 1NY Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 77509780001 | |||||||||
BURNLEY, John Lewis | Administrateur | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | Quantity Surveyor | 35543830001 | ||||||||
DI CIACCA, Cesidio Martin | Administrateur | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | Director | 1267050001 | ||||||||
DUNCAN, Andrew Raymond | Administrateur | Fearann-Nan-Gras Kilmuir, North Kessock IV1 3ZG Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Financial Consultant | 63676750001 | ||||||||
FINLAY, Mark James | Administrateur | 4 Croft Rise Croft Road BT18 0QG Holywood Belfast | Northern Ireland | British | Chartered Surveyor | 115223630001 | ||||||||
FRASER, George Gabriel | Administrateur | 7 Fairways Altonburn Road IV12 5NB Nairn Highland | Scotland | British | Director | 50219540001 | ||||||||
MCBRIDE, Stephen Paul | Administrateur | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | Financial Controller | 56953000002 | ||||||||
MCCABE, Kevin Charles | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England | England | British | Chartered Surveyor | 109250000012 | ||||||||
MCCABE, Kevin Charles | Administrateur | 1000 Brussels Franklin Roosevelt 135 Belgium | British | Director | 109250000007 | |||||||||
MCCABE, Simon Charles | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | Development Executive | 154915110001 | ||||||||
MCCABE, Simon Charles | Administrateur | 5 Rothesay Mews EH3 7SG Edinburgh | British | Development Executive | 103888320001 | |||||||||
MCGOUGAN, Thomas | Administrateur | Hilcote Bishops Road IV10 8TR Fortrose Ross Shire | Scotland | British | Director | 46105240001 | ||||||||
MURRAY, Alan Adams | Administrateur | 3 Otterburn Park EH14 1JX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Consultant | 559270001 | ||||||||
SUTHERLAND, David Fraser | Administrateur | Oldtown Of Leys Farm Culduthel IV2 6AE Inverness | Scotland | British | Director | 1321720003 | ||||||||
TANDY, Didier Michel | Administrateur | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | Chartered Surveyor | 69909950001 | ||||||||
TRACE, Marjory Bremner | Administrateur | 1 Wellside Road Balloch IV2 7GS Inverness | British | Company Secretary | 43522850004 | |||||||||
ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430390001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarborough Group Limited | 28 févr. 2017 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Scarborough Holdings Limited | 06 avr. 2016 | The Castle Business Park FK9 4TU Stirling Lomond Court Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Créé le 08 juin 2011 Livré le 14 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects on the south side of cumbernauld road stepps glasgow GLA16398 and GLA182047 under exception of those subjects known as and forming buildings 2 and 7 buchanan gate cumbernauld road stepps glasgow GLA202885. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 08 juin 2011 Livré le 14 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects on the south side of cumbernauld road stepps glasgow.gla 16398 and GLA182047 under exception of those subjects known and forming buildings 2 and 7 buchanan gate cumbernauld road stepps glasgow GLA202885. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 06 juin 2011 Livré le 14 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 7 9 11 13 15 and 17 union street and 33 35 37 39 and 41 baron taylors street inverness INV7030. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 06 juin 2011 Livré le 14 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 7 9 11 13 15 and 17 union street and 33 35 37 39 and 41 baron taylors street inverness INV7030. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 03 juin 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over ground on south side of cumbernauld roads, stepps, glasgow GLA16398 under exception of GLA202885). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 03 juin 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over over ground on south side of cumbernauld roads, stepps, glasgow GLA16398 under exception of GLA202885). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 03 juin 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 7,9,11,13, 15 & 17 union street & 33, 35, 37, 39 & 41 baron taylors street, inverness INV7030). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rents | Créé le 03 juin 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 7,9,11,13, 15 & 17 union street & 33, 35, 37, 39 & 41 baron taylors street, inverness INV7030). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 mai 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Debenture | Créé le 20 mai 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 20 mai 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 20 mai 2011 Livré le 03 juin 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Standard security | Créé le 18 juil. 2005 Livré le 29 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 20.3 acres of ground at cumbernauld road, stepps, glasgow GLA182047. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 30 juin 2004 Livré le 14 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Unit 3, 180 festival court, brand street, govan, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 04 févr. 2004 Livré le 05 févr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 29 january 2004 | |
Brèves mentions 7, 9, 11, 13, 15 and 17 union street and 33-37 and 39-41 baron taylor's street, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 23 janv. 2004 Livré le 30 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 70 carron road, falkirk. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 23 janv. 2004 Livré le 30 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Units 1 & 2, festival court, brand street, govan, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 08 juil. 2002 Livré le 18 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 21 june 2002 | |
Brèves mentions The property known as house and grounds at stoneyfield, inverness and lands to the north of the A96 at stoneyfield, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 19 févr. 2002 Livré le 04 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond executed by the company on 1 february 2002 | |
Brèves mentions Areas of ground on the west side of grampian road, in the village of aviemore and county of inverness and the buildings, erections, fixtures and fittings thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 févr. 2002 Livré le 22 févr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of a personal bond executed by the company on 19 october 2001 | |
Brèves mentions Area of ground extending to 133 square yards at main street, kyle of lochalsh, parish of lochalsh and county of ross and cromarty. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 janv. 2002 Livré le 21 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground extending to 4.03 hectares or thereby lying generally on or towards the east of dunvegan road, portree. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 janv. 2002 Livré le 21 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 2 areas of ground lying on the south of ruthvenfield road, perth. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 janv. 2002 Livré le 21 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions On the south side of cumbernauld road, stepps, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 janv. 2002 Livré le 21 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground extending to 133 square yards in the burgh of kyle of lachalsh and county of ross and cromarty. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 janv. 2002 Livré le 21 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground extending to 0.460 hectares or thereby lying generally to the south of the A96 trunk road from inverness to nairn. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0