SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED

SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC222340
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mazars Llp Apex 2
    97 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SDG PROPERTY HOLDINGS LIMITED03 déc. 200303 déc. 2003
    SDG (SCOTLAND) LIMITED15 mai 200315 mai 2003
    TEESLOCH LIMITED23 nov. 200123 nov. 2001
    TEESLOCH PROPERTIES LIMITED17 août 200117 août 2001

    Quels sont les derniers comptes de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    8 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ Scotland à C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD le 19 mai 2021

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 févr. 2021

    LRESSP

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ

    2 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Simon Charles Mccabe en tant que directeur le 15 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Charles Mccabe en tant que directeur le 15 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeremy John Tutton en tant qu'administrateur le 01 août 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Esplanade Director Limited en tant que directeur le 26 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland à C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ le 01 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 26 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 26 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2019

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU à C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 04 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2018

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Kevin Charles Mccabe en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2017

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director151895310001
    TUTTON, Jeremy John
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller113787520002
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor77509780001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Administrateur
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    ScotlandBritishSolicitor40585290002
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor77509780001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Administrateur
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritishQuantity Surveyor35543830001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector1267050001
    DUNCAN, Andrew Raymond
    Fearann-Nan-Gras
    Kilmuir, North Kessock
    IV1 3ZG Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    Fearann-Nan-Gras
    Kilmuir, North Kessock
    IV1 3ZG Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishFinancial Consultant63676750001
    FINLAY, Mark James
    4 Croft Rise
    Croft Road
    BT18 0QG Holywood
    Belfast
    Administrateur
    4 Croft Rise
    Croft Road
    BT18 0QG Holywood
    Belfast
    Northern IrelandBritishChartered Surveyor115223630001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Administrateur
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritishDirector50219540001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishChartered Surveyor109250000012
    MCCABE, Kevin Charles
    1000 Brussels
    Franklin Roosevelt 135
    Belgium
    Administrateur
    1000 Brussels
    Franklin Roosevelt 135
    Belgium
    BritishDirector109250000007
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDevelopment Executive154915110001
    MCCABE, Simon Charles
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    Administrateur
    5 Rothesay Mews
    EH3 7SG Edinburgh
    BritishDevelopment Executive103888320001
    MCGOUGAN, Thomas
    Hilcote
    Bishops Road
    IV10 8TR Fortrose
    Ross Shire
    Administrateur
    Hilcote
    Bishops Road
    IV10 8TR Fortrose
    Ross Shire
    ScotlandBritishDirector46105240001
    MURRAY, Alan Adams
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishConsultant559270001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritishDirector1321720003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Administrateur
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    BritishCompany Secretary43522850004
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scarborough Group Limited
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    28 févr. 2017
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementU.K.
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement5308255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Scarborough Holdings Limited
    The Castle Business Park
    FK9 4TU Stirling
    Lomond Court
    Scotland
    06 avr. 2016
    The Castle Business Park
    FK9 4TU Stirling
    Lomond Court
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementU.K.
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc222296
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 08 juin 2011
    Livré le 14 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on the south side of cumbernauld road stepps glasgow GLA16398 and GLA182047 under exception of those subjects known as and forming buildings 2 and 7 buchanan gate cumbernauld road stepps glasgow GLA202885.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 08 juin 2011
    Livré le 14 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on the south side of cumbernauld road stepps glasgow.gla 16398 and GLA182047 under exception of those subjects known and forming buildings 2 and 7 buchanan gate cumbernauld road stepps glasgow GLA202885.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 juin 2011
    Livré le 14 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 9 11 13 15 and 17 union street and 33 35 37 39 and 41 baron taylors street inverness INV7030.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 juin 2011
    Livré le 14 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 9 11 13 15 and 17 union street and 33 35 37 39 and 41 baron taylors street inverness INV7030.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 03 juin 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over ground on south side of cumbernauld roads, stepps, glasgow GLA16398 under exception of GLA202885).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 03 juin 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over over ground on south side of cumbernauld roads, stepps, glasgow GLA16398 under exception of GLA202885).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 03 juin 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 7,9,11,13, 15 & 17 union street & 33, 35, 37, 39 & 41 baron taylors street, inverness INV7030).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 03 juin 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole right, title and interest in and to the assigned rights (over 7,9,11,13, 15 & 17 union street & 33, 35, 37, 39 & 41 baron taylors street, inverness INV7030).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 18 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    20.3 acres of ground at cumbernauld road, stepps, glasgow GLA182047.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 14 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 3, 180 festival court, brand street, govan, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 04 févr. 2004
    Livré le 05 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 29 january 2004
    Brèves mentions
    7, 9, 11, 13, 15 and 17 union street and 33-37 and 39-41 baron taylor's street, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 janv. 2004
    Livré le 30 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    70 carron road, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 janv. 2004
    Livré le 30 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1 & 2, festival court, brand street, govan, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 08 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 21 june 2002
    Brèves mentions
    The property known as house and grounds at stoneyfield, inverness and lands to the north of the A96 at stoneyfield, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 19 févr. 2002
    Livré le 04 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond executed by the company on 1 february 2002
    Brèves mentions
    Areas of ground on the west side of grampian road, in the village of aviemore and county of inverness and the buildings, erections, fixtures and fittings thereon.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 2002
    Livré le 22 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond executed by the company on 19 october 2001
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 133 square yards at main street, kyle of lochalsh, parish of lochalsh and county of ross and cromarty.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 4.03 hectares or thereby lying generally on or towards the east of dunvegan road, portree.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 areas of ground lying on the south of ruthvenfield road, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    On the south side of cumbernauld road, stepps, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 133 square yards in the burgh of kyle of lachalsh and county of ross and cromarty.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 janv. 2002
    Livré le 21 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 0.460 hectares or thereby lying generally to the south of the A96 trunk road from inverness to nairn.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SCARBOROUGH GROUP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2022Due to be dissolved on
    12 févr. 2021Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0