TIGERMETAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIGERMETAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC223218
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIGERMETAL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TIGERMETAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rowallan Business Park
    Southcraig Avenue
    KA3 6BQ Kilmarnock
    Ayrshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TIGERMETAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FOOD PARTNERS HOLDINGS LIMITED27 févr. 200227 févr. 2002
    SANDCIRCLE LIMITED14 sept. 200114 sept. 2001

    Quels sont les derniers comptes de TIGERMETAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 oct. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TIGERMETAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TIGERMETAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Steve Wood en tant que directeur le 31 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2012

    État du capital au 03 déc. 2012

    • Capital: GBP 28,957,100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Steve Wood le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Gavin Cox le 01 nov. 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gavin Cox le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 avr. 2012

    • Capital: GBP 28,957,100
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Certificat de changement de nom

    Company name changed food partners holdings LIMITED\certificate issued on 27/04/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    27 avr. 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Paul Kingsley-Bates en tant que directeur le 28 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Gavin Cox en tant que secrétaire le 01 oct. 2011

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Julian Akhtar Karim Momen en tant que directeur le 01 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julian Akhtar Karim Momen en tant que secrétaire le 01 oct. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Nomination de Steve Wood en tant qu'administrateur le 01 sept. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 02 oct. 2010

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gavin Cox le 02 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Gavin Cox en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 03 oct. 2009

    15 pagesAA

    Nomination de Julian Akhtar Karim Momen en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de TIGERMETAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Gavin
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Secrétaire
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    165757080001
    COX, Gavin Eliot
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    United Kingdom
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63844650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    Secrétaire
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    British150619500001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Secrétaire
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    P & W SECRETARIES LIMITED
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    900021250001
    ANDERSON, Stuart Anthony Kidston
    Allee Du Cloitre 7
    FOREIGN Brussels
    1000
    Belgium
    Administrateur
    Allee Du Cloitre 7
    FOREIGN Brussels
    1000
    Belgium
    BritishDirector71513420001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Administrateur
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY-BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director193929530001
    LAINE, Jean-Claude
    Montan
    31450 Montbrun-Les
    France
    Administrateur
    Montan
    31450 Montbrun-Les
    France
    FrenchFem Partner94945290001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Administrateur
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Administrateur
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Administrateur
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishDirector63448390001
    THORNE, Mike
    40 Lancaster Mews
    W2 3QF London
    England
    Administrateur
    40 Lancaster Mews
    W2 3QF London
    England
    BritishDirector71735980004
    THUFASON, Henrik
    Casa Aslan
    29754 Competa (Malaga)
    Spain
    Administrateur
    Casa Aslan
    29754 Competa (Malaga)
    Spain
    DanishBanker90841950001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    WRIGHT, Robin James Morrison
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    Administrateur
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector71513490001
    P & W DIRECTORS LIMITED
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    Administrateur désigné
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    900021240001

    TIGERMETAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 02 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over property, assets and intellectual property including security assignments and floating charge over whole assets of the company - see form 410 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Duke Street Capital General Partner Limited
    Transactions
    • 02 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 04 avr. 2006
    Livré le 21 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 avr. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 avr. 2006
    Livré le 21 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 avr. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 31 oct. 2001
    Livré le 07 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0