CONTACT ADVANTAGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONTACT ADVANTAGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC223411
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 South Charlotte Street
    EH2 4AN Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 64a Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE Scotland à 5 South Charlotte Street Edinburgh EH2 4AN le 14 févr. 2023

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Sheri Anne Robinson le 10 janv. 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Turpin Daughters Ii le 10 janv. 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Norman Tommy Barras le 10 janv. 2023

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert David Burnett en tant que directeur le 01 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Christopher Brian Walsh en tant qu'administrateur le 26 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Pamela Wright Lugo en tant que secrétaire le 01 févr. 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jeffrey Scott Cherry en tant que directeur le 26 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jeffrey Scott Cherry en tant que secrétaire le 01 févr. 2022

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Pavillion 2 363 Helen Street Glasgow G51 3AD à 64a Cumberland Street Edinburgh EH3 6RE le 12 janv. 2022

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Ucs Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Cessation de Ucs Systems Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 mai 2021

    1 pagesPSC07

    Nomination de Ms Sheri Anne Robinson en tant qu'administrateur le 22 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Turpin Daughters Ii en tant qu'administrateur le 22 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jeffrey Scott Cherry en tant qu'administrateur le 22 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jeffrey Scott Cherry en tant que secrétaire le 22 déc. 2020

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LUGO, Pamela Wright
    c/o Andrew Partridge
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    Secrétaire
    c/o Andrew Partridge
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    292291630001
    BARRAS, Norman Tommy
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    Administrateur
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    United StatesAmericanBusiness Executive84053860001
    DAUGHTERS II, William Turpin
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    Administrateur
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    United StatesAmericanExecutive277917100001
    ROBINSON, Sheri Anne
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    Administrateur
    Reynolds 1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    C/O Andrew Partridge
    England
    United StatesAmericanExecutive277916710001
    WALSH, Christopher Brian
    c/o Andrew Partridge
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    Administrateur
    c/o Andrew Partridge
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    United StatesAmericanEvp Sales292290250001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    BritishAccountant15959630001
    CHERRY, Jeffrey Scott
    Hollister
    Houston
    6700
    Texas 77040
    United States
    Secrétaire
    Hollister
    Houston
    6700
    Texas 77040
    United States
    277933840001
    MCHARG, Cornelius Deacon
    55 Mearns Road
    G76 7ES Clarkston
    Lanarkshire
    Secrétaire
    55 Mearns Road
    G76 7ES Clarkston
    Lanarkshire
    British126547910001
    MCKENNA, David Francis
    190-192 Carlisle Road
    Blackwood
    ML11 9SB Lanark
    Secrétaire
    190-192 Carlisle Road
    Blackwood
    ML11 9SB Lanark
    BritishDirector104215590001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    BritishDirector162220750001
    MOSS, Michael Craig
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Secrétaire
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    201739460001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South AfricanDirector97879810002
    COSEC LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003850001
    HMS SECRETARIES LIMITED
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Secrétaire désigné
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    900004320001
    AGAN, Dan Steven
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive84053880001
    BROCKMAN, Robert Theron
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive158497330001
    BROMLEY, James
    Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    7
    Surrey
    Administrateur
    Mill Place
    KT1 2RS Kingston Upon Thames
    7
    Surrey
    BritishDirector128836230001
    BRYCE, Paul
    6 Hebrides Grove
    Inverkip Marina
    PA16 0BQ Inverkip
    Administrateur
    6 Hebrides Grove
    Inverkip Marina
    PA16 0BQ Inverkip
    BritishDirector79519270002
    BURNETT, Robert David
    Cumberland Street
    EH3 6RE Edinburgh
    64a
    Scotland
    Administrateur
    Cumberland Street
    EH3 6RE Edinburgh
    64a
    Scotland
    United StatesAmericanBusiness Executive121495910001
    CHERRY, Jeffrey Scott
    Hollister
    Houston
    6700
    Texas 77040
    United States
    Administrateur
    Hollister
    Houston
    6700
    Texas 77040
    United States
    United StatesAmericanGeneral Counsel277917490001
    COOPER, Carlan Max
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    UsaUnited StatesBusiness Executive136536270001
    HIERS, William Ardis
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive201030300001
    JONES, Terry Wallace
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive84053830001
    LEWIS, Robert James
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    EnglandBritishCompany Director83629470002
    LEWIS, Robert James
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Scotland
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Scotland
    EnglandBritishDirector83629470002
    MCGOWAN, Derek
    83 Old Greenock Road
    PA7 5BE Bishopton
    Administrateur
    83 Old Greenock Road
    PA7 5BE Bishopton
    ScotlandBritishDirector79519030001
    MCGOWAN, Derek
    83 Old Greenock Road
    PA7 5BE Bishopton
    Administrateur
    83 Old Greenock Road
    PA7 5BE Bishopton
    ScotlandBritishDirector79519030001
    MCHARG, Neil
    55 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7ES Glasgow
    Administrateur
    55 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7ES Glasgow
    United KingdomBritishDirector30993940003
    MCKENNA, David Francis
    190-192 Carlisle Road
    Blackwood
    ML11 9SB Lanark
    Administrateur
    190-192 Carlisle Road
    Blackwood
    ML11 9SB Lanark
    BritishDirector104215590001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector162220750001
    MOSS, Michael Craig
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive121496770001
    NALLEY, Robert Maxey
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    Administrateur
    363 Helen Street
    G51 3AD Glasgow
    Pavillion 2
    United StatesAmericanBusiness Executive84053700001
    STOREY, Graham Neil
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director48939070004
    CODIR LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003840001
    COSEC LIMITED
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    78 Montgomery Street
    EH7 5JA Edinburgh
    Lothian
    900003850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CONTACT ADVANTAGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ucs Systems Limited
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    06 avr. 2016
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4258232
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Ucs Systems Limited
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    06 avr. 2016
    Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    1200
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4258232
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CONTACT ADVANTAGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 2007
    Livré le 17 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 16 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0