MACDUFF FISHING FLEET LIMITED

MACDUFF FISHING FLEET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACDUFF FISHING FLEET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC224009
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    • Pêche maritime (03110) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o PINSENT MASONS LLP
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTT TRAWLERS LIMITED08 oct. 200108 oct. 2001

    Quels sont les derniers comptes de MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Ms Nicole Rachel Henneberry en tant qu'administrateur le 12 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Darryl Andrew Bergman en tant que directeur le 12 juil. 2024

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    État du capital au 26 mars 2024

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 26 mars 2024

    • Capital: GBP 2,940,918
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge SC2240090070 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2240090071 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2240090072 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2240090073 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2022 au 30 juin 2023

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Teresa Helen Joyce Fortney en tant que directeur le 31 mai 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Darryl Andrew Bergman en tant qu'administrateur le 01 juin 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 févr. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Vincent James Strachan en tant qu'administrateur le 25 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael George Mcintyre en tant que directeur le 25 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02318923
    76579530001
    BROWN, Andrew Donald, Dr
    Station Road
    AB42 5EE Mintlaw
    Macduff Shellfish (Scotland) Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    AB42 5EE Mintlaw
    Macduff Shellfish (Scotland) Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector Of Sustainability And Public Affairs269081130001
    HENNEBERRY, Nicole Rachel
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    CanadaCanadianFinance325080170001
    KELLY, Telaina
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianVice President, Legal & Corporate Secretary246058820001
    MITCHELITIS, Shaun
    1st Floor Arthur Road
    SL4 1SE Windsor
    Kardleton House
    United Kingdom
    Administrateur
    1st Floor Arthur Road
    SL4 1SE Windsor
    Kardleton House
    United Kingdom
    United KingdomCanadianVice President Of Sales, Emea260391750001
    STRACHAN, Vincent James
    AB42 5EE Peterhead
    Station Road
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Administrateur
    AB42 5EE Peterhead
    Station Road
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinancial Controller, Macduff Shellfish (Scotland)292225730001
    LESLIE, Derek
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza (6th Floor)
    Scotland
    Secrétaire
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza (6th Floor)
    Scotland
    British175006730001
    MURRAY, Graeme Alexander
    66 Ness Circle
    AB41 9BR Ellon
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    66 Ness Circle
    AB41 9BR Ellon
    Aberdeenshire
    British69955970002
    SCOTT, Ben Anthony
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    Shealinghill
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    Shealinghill
    Dumfriesshire
    United Kingdom
    British139943150001
    BEATON, Euan Drummond
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    United KingdomBritishChairman86511820001
    BERGMAN, Darryl Andrew
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    CanadaCanadianVice President, Finance And Chief Financial Office296493340001
    BROWN, Andrew Donald, Dr
    Station Road
    AB42 5EE Mintlaw
    Macduff Shellfish (Scotland) Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    AB42 5EE Mintlaw
    Macduff Shellfish (Scotland) Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector Of Sustainability And Public Affairs269081130001
    CARGO, Janice Tanya
    272 Kings Road
    SW3 5AW London
    College House
    Uk
    Administrateur
    272 Kings Road
    SW3 5AW London
    College House
    Uk
    EnglandBritishInvestment Professional159812190001
    CUNNINGHAM, Roy Macgregor
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pinsent Masons Llp
    Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    13
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director169523760002
    FORTNEY, Teresa Helen Joyce
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianChief Financial Officer292200660001
    FORTNEY, Teresa Helen Joyce
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianChief Financial Officer209913590001
    GRAY, Nicholas
    Station Road
    AB42 4LU Mintlaw
    Macduff Shellfish
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    AB42 4LU Mintlaw
    Macduff Shellfish
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandScottishFinance Director160700800001
    HOLLIS, Michael Theodore
    4th Floor
    50 Mark Lane
    EC3R 7QR London
    Tricor Suite
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor
    50 Mark Lane
    EC3R 7QR London
    Tricor Suite
    United Kingdom
    United KingdomAmericanDirector Of Sales, Emea202080350001
    KALUTYCZ, William Dion
    Shellbridge Way
    V6X 3C6 Richmond
    100-10991
    British Columbia
    Canada
    Administrateur
    Shellbridge Way
    V6X 3C6 Richmond
    100-10991
    British Columbia
    Canada
    CanadaCanadianChief Financial Officer279406190001
    KAVANAGH, David John
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianLawyer201635590001
    KELLY, Telaina
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    B4A327 Bedford
    757
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianVice President, Legal & Corporate Secretary246058820001
    LESLIE, Derek Cameron
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza (6th Floor)
    Scotland
    Administrateur
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza (6th Floor)
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director135400010003
    MCINTYRE, Michael George
    Membertou Street
    B1S 2M9 Membertou
    111
    Nova Scotia
    Canada
    Administrateur
    Membertou Street
    B1S 2M9 Membertou
    111
    Nova Scotia
    Canada
    CanadaCanadianBusinessman279404890001
    MITCHELITIS, Shaun
    1st Floor Arthur Road
    SL4 1SE Windsor
    Kardleton House
    United Kingdom
    Administrateur
    1st Floor Arthur Road
    SL4 1SE Windsor
    Kardleton House
    United Kingdom
    United KingdomCanadianVice President Of Sales, Emea260391750001
    SCOTT, Andrew John
    Shealinghill
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    Administrateur
    Shealinghill
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    ScotlandBritishFishing Vessel Owner27173420001
    SCOTT, Marc Andrew
    Shealinghill
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Shealinghill
    Lochfoot
    DG2 8NJ Dumfries
    Dumfriesshire
    BritishEngineer111576730001
    WIGHT, Robert Derek
    Bedford Highway
    Bedford
    B4A327 Nova Scotia
    757
    Canada
    Administrateur
    Bedford Highway
    Bedford
    B4A327 Nova Scotia
    757
    Canada
    CanadaCanadianAccountant201635610001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACDUFF FISHING FLEET LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    13 Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    13 Queen's Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc395532
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MACDUFF FISHING FLEET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 13 août 2021
    Livré le 25 août 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 25 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2021
    Livré le 24 août 2021
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 24 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2021
    Livré le 24 août 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 24 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 13 août 2021
    Livré le 24 août 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 24 août 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2021
    Livré le 10 févr. 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 10 févr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2021
    Livré le 10 févr. 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 10 févr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2021
    Livré le 10 févr. 2021
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 10 févr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2021
    Livré le 04 févr. 2021
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Montreal as Agent and Security Trustee for the Secured Parties Under the Credit Agreement and the Security Trust Deed as Defined in the Instrument Evidencing the Charge Accompanying This Form MR01.
    Transactions
    • 04 févr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2016
    Livré le 07 sept. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., Canadian Branch and Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees
    Transactions
    • 07 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2016
    Livré le 07 sept. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., Canadian Branch and Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees
    Transactions
    • 07 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2016
    Livré le 06 sept. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., Canadian Branch and Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees
    Transactions
    • 06 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2016
    Livré le 06 sept. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., Canadian Branch and Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees
    Transactions
    • 06 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 janv. 2016
    Livré le 19 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as albion registered under UK flag with official number B13827 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 19 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2015
    Livré le 30 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The company as beneficial legal owner of the ships with full title guarantee mortgages and charges all its right, title and interest present and future in and to the mortgaged property to and in favour of the agent.. (See attached deed of covenant for full details and defined terms).
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors, Permitted Assignees and Permitted Transferees
    Transactions
    • 30 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 14 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors in Title, Permitted Assigns and Permitted Transferees
    Transactions
    • 14 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 14 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors in Title, Permitted Assigns and Permitted Transferees
    Transactions
    • 14 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 11 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors, Assignees and Transferees
    Transactions
    • 11 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 11 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors, Assignees and Transferees
    Transactions
    • 11 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 11 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company and Its Successors, Assignees and Transferees
    Transactions
    • 11 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2015
    Livré le 10 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company Its Successors in Title and Assigns
    Transactions
    • 10 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2015
    Livré le 17 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as tjeerd jacoba registered under UK flag with official number A15179 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 17 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2015
    Livré le 17 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as sylvia bowers registered under UK flag with official number C17098 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 17 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2015
    Livré le 17 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as honeybourne iii registered under UK flag with official number B12744 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 17 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2015
    Livré le 17 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as vertrouwen registered under UK flag with official number B10005 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 17 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2015
    Livré le 17 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    64 shares in the vessel known as glendeveron registered under UK flag with official number A14820 and its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Ge Canada Finance Holding Company
    Transactions
    • 17 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 févr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0