VION SUBCO GCFI LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVION SUBCO GCFI LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC224504
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRAMPIAN COUNTRY FOODS INTERNATIONAL LIMITED06 nov. 200106 nov. 2001
    ISANDCO THREE HUNDRED AND EIGHTY FIVE LIMITED24 oct. 200124 oct. 2001

    Quels sont les derniers comptes de VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA à C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 23 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 avr. 2015

    LRESSP

    État du capital au 24 févr. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 nov. 2014

    État du capital au 20 nov. 2014

    • Capital: GBP 16,113,400
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* le 12 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 oct. 2013

    État du capital au 25 oct. 2013

    • Capital: GBP 16,113,400
    SH01

    Nomination de Mr Leon Barry Abbitt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Steven en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Louis Vernaus en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Maarten Kusters en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed grampian country foods international LIMITED\certificate issued on 04/04/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 avr. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name04 avr. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Francis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Maarten Kusters en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Christiaanse en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de VION SUBCO GCFI LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    IAIN SMITH & COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire désigné
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    900000570001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritish105961550001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Administrateur
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Dutch126350570004
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish194640001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001
    SMITH, Malcolm
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish93227360001
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001

    VION SUBCO GCFI LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 19 nov. 2001
    Livré le 29 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leaseholdproperty in scotland and all buildings and fixtures thereon; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 nov. 2001
    Livré le 29 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    VION SUBCO GCFI LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 avr. 2015Commencement of winding up
    02 sept. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0