BAKER RDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAKER RDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC224905
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAKER RDS LIMITED ?

    • Activités de soutien à l'extraction de pétrole et de gaz naturel (09100) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe BAKER RDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kirkhill Road Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAKER RDS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HELIX RDS LIMITED04 déc. 200104 déc. 2001
    RANGEPACK LIMITED02 nov. 200102 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de BAKER RDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BAKER RDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 janv. 2022

    LRESSP

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital après une attribution d'actions au 10 janv. 2022

    • Capital: GBP 4,191,835
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    22 pagesAA

    Nomination de Mr Alexandre Makram-Ebeid en tant qu'administrateur le 26 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Oluwole Onabolu en tant que directeur le 26 mars 2019

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Baker Energy Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    23 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bla Al Mcleish le 12 juin 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Bla Al Mcleish en tant qu'administrateur le 12 juin 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Allan Rasmuson en tant que directeur le 12 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    26 pagesAA

    Nomination de Mr Oluwole Onabolu en tant qu'administrateur le 10 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Dominic Upton en tant que directeur le 10 févr. 2017

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen Aberdeen AB12 4YB Scotland à Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate Portlethen Aberdeen AB12 4YB

    1 pagesAD02

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Badentoy Avenue Badentoy Industrial Estate, Portlethen Aberdeen AB12 4YB

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de BAKER RDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNLOP, Lorraine Amanda
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Secrétaire
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    212595190001
    MAKRAM-EBEID, Alexandre
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    EnglandBritishDirector256924730001
    MCLEISH, Blair Alexander
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    United KingdomBritishDirector168993360002
    KLASSEN, Jenni Therese
    Stoneywood Park North
    Dyce
    AB21 7EA Aberdeen
    Baker Hughes Building
    Scotland
    Secrétaire
    Stoneywood Park North
    Dyce
    AB21 7EA Aberdeen
    Baker Hughes Building
    Scotland
    189709250001
    SMITH, George Wilson
    2 Brighton Place
    AB10 6RS Aberdeen
    Secrétaire
    2 Brighton Place
    AB10 6RS Aberdeen
    British58303320002
    STOKES, Paul Bryan
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    United Kingdom
    British121660190001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    P & W SECRETARIES LIMITED
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    900021250001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    ASQUITH, Christopher
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Adviser17673120004
    BUSTER III, H Clifford
    12458 Lago Bend Lane
    77041 Houston
    Texas
    Usa
    Administrateur
    12458 Lago Bend Lane
    77041 Houston
    Texas
    Usa
    AmericanDirector121388910001
    CONNOR III, James Lewis
    50 Highland Circle
    The Woodlands
    77381 Texas
    77381
    Usa
    Administrateur
    50 Highland Circle
    The Woodlands
    77381 Texas
    77381
    Usa
    AmericanDirector82742770001
    FERRON, Martin Robert
    95 Trinity Oaks Circle
    77381 The Woodlands
    Texas
    Usa
    Administrateur
    95 Trinity Oaks Circle
    77381 The Woodlands
    Texas
    Usa
    BritishDirector82876390001
    HAJDIK, Lloyd
    8803 Ashridge Park Drive
    77379 Spring
    Texas
    United States
    Administrateur
    8803 Ashridge Park Drive
    77379 Spring
    Texas
    United States
    UsaAmericanDirector134455150001
    HARRIS, John David
    c/o Baker Hughes
    Floor Building 5
    Chiswick Park 566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    3rd
    Administrateur
    c/o Baker Hughes
    Floor Building 5
    Chiswick Park 566 Chiswick High Road
    W4 5YF London
    3rd
    ScotlandBritishDirector131358880001
    HARRIS, John David
    Auchnacant House Newburgh
    AB41 8LY Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Auchnacant House Newburgh
    AB41 8LY Ellon
    Aberdeenshire
    BritishDirector52015040001
    JOHNSON, Alisa Berne
    5628 San Felipe
    Houston
    Texas 77056
    Administrateur
    5628 San Felipe
    Houston
    Texas 77056
    United StatesAmericanAttorney116695990001
    KAYES, Toby
    Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    68
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    68
    Aberdeenshire
    BritishEngineer138068680001
    KRATZ, Owen Eugene
    204 Travis Street
    Apt 8-A
    77002 Houston
    Texas
    Usa
    Administrateur
    204 Travis Street
    Apt 8-A
    77002 Houston
    Texas
    Usa
    United StatesBritishDirector82876570001
    MAYS, Elaine Doris
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    Administrateur
    Floor Building 5 Chiswick Park
    566 Chiswick High Road Chiswick
    W4 5YF London
    3rd
    ScotlandBritishLawyer196074340001
    MOORE, Philip Christian
    Crenelle 17 Hillhead Road
    Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    Administrateur
    Crenelle 17 Hillhead Road
    Bieldside
    AB15 9EJ Aberdeen
    BritishCompany Director58303290001
    ONABOLU, Oluwole
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    United Arab EmiratesNigerianLawyer224865990001
    ONABOLU, Oluwole
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JL Aberdeen
    Peregrine Road
    Administrateur
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JL Aberdeen
    Peregrine Road
    United KingdomNigerianCorporate Legal Adviser171308090002
    RASMUSON, Michael Allan, Mr.
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    EnglandCanadianLawyer98354440002
    SMITH, George Wilson
    2 Brighton Place
    AB10 6RS Aberdeen
    Administrateur
    2 Brighton Place
    AB10 6RS Aberdeen
    United KingdomBritishChartered Accountant58303320002
    UPTON, John Dominic
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    Administrateur
    Kirkhill Industrial Estate
    Dyce
    AB21 0GQ Aberdeen
    Kirkhill Road
    Scotland
    EnglandBritishLawyer207648640001
    P & W DIRECTORS LIMITED
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    Administrateur désigné
    Investment House
    6 Union Row
    AB21 7DQ Aberdeen
    900021240001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BAKER RDS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GQ Dyce
    Kirkhill Road
    Aberdeen
    Scotland
    06 avr. 2016
    Kirkhill Industrial Estate
    AB21 0GQ Dyce
    Kirkhill Road
    Aberdeen
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc207740
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BAKER RDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 28 mars 2002
    Livré le 04 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Site 6A westhill business park, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charge over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 avr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    BAKER RDS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 févr. 2024Due to be dissolved on
    11 janv. 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0