STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC225035 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o KPMG LLP Saltire Court, 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 4 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 151 West George Street Glasgow G2 2JJ Scotland le 07 août 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Andrew Weir Duncan en tant que secrétaire le 27 juin 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2011 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 180 st. Vincent Street Glasgow G2 5SG United Kingdom le 25 oct. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Macleod en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Donald Ewen Macleod le 09 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2008 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 4 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed halladale ventures (scotland) LIMITED\certificate issued on 30/06/08 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKIN, Mark James | Administrateur | 5 Macnicol Park Kittochglen G74 4QE East Kilbride | Scotland Uk | British | 42293490004 | |||||
| LINDSAY, Kenneth Fraser | Administrateur | 61 Muir Wood Crescent Currie EH14 5HB Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 121520410001 | |||||
| DUNCAN, Stuart Andrew Weir | Secrétaire | 16 Woodlands Terrace G3 6DF Glasgow | British | 80233100002 | ||||||
| HARKIN, Mark James | Secrétaire | 5 Macnicol Park Kittochglen G74 4QE East Kilbride | British | 42293490004 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Administrateur | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Administrateur | 18 Clayhills Grove EH14 7NE Balerno Midlothian | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||
| HEWITT, Alistair James Neil | Administrateur | 12 Annickbank Stewarton KA3 5QT Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 113081830001 | |||||
| LOCKHART, David Alfred Stevenson | Administrateur | 5 Carlton Terrace EH7 5DD Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 35520610001 | |||||
| MACKINTOSH, Iain Stewart | Administrateur | 90 Flat 2 Mayfield Road Newington EH9 2NJ Edinburgh | British | 80118270001 | ||||||
| MACLEOD, Alan Donald Ewen | Administrateur | 12 Violet Terrace EH11 1NZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 107116780001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 03 févr. 2006 Livré le 17 févr. 2006 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property now or in the future belonging to it and located in england or wales (see attached schedule) including fixed and floating charges. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 03 févr. 2006 Livré le 16 févr. 2006 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental debenture | Créé le 31 mars 2005 Livré le 14 avr. 2005 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession | Créé le 31 mars 2005 Livré le 14 avr. 2005 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 mai 2002 Livré le 29 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document | |
Brèves mentions Subjects known as the bargarren centre, barrhill road, erskine (title number REN34783). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 mai 2002 Livré le 29 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document | |
Brèves mentions Subjects known as 6/14 church street and 6 baron taylor's street, inverness together with buildings and erections thereon and right, title and interest. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 mai 2002 Livré le 29 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document | |
Brèves mentions Subjects known as 22 and 24 cambridge street, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 mai 2002 Livré le 29 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document | |
Brèves mentions The tenant's interest in the lease over subjects known as 158-204 main street, barrhead. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 08 mai 2002 Livré le 17 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document | |
Brèves mentions Gross rental income over 22 and 24 cambridge street, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 08 mai 2002 Livré le 17 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document | |
Brèves mentions The gross rental income over the tenant's interest in 158-204 main street, barrhead. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 08 mai 2002 Livré le 17 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document | |
Brèves mentions The gross rental income over 6/14A church street and 6 baron taylor's street, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 08 mai 2002 Livré le 17 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document | |
Brèves mentions The gross rental income over the barrangate centre, barhill road, erskine. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 mai 2002 Livré le 17 mai 2002 | En cours | Montant garanti All sums due under the finance documents | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0