STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED

STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC225035
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    Saltire Court,
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALLADALE VENTURES (SCOTLAND) LIMITED25 févr. 200225 févr. 2002
    PACIFIC SHELF 1097 LIMITED07 nov. 200107 nov. 2001

    Quels sont les derniers comptes de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    4 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 151 West George Street Glasgow G2 2JJ Scotland le 07 août 2012

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 août 2012

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Stuart Andrew Weir Duncan en tant que secrétaire le 27 juin 2012

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 nov. 2011

    État du capital au 22 nov. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 180 st. Vincent Street Glasgow G2 5SG United Kingdom le 25 oct. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Macleod en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Donald Ewen Macleod le 09 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2008

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed halladale ventures (scotland) LIMITED\certificate issued on 30/06/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Administrateur
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Scotland UkBritish42293490004
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish121520410001
    DUNCAN, Stuart Andrew Weir
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    Secrétaire
    16 Woodlands Terrace
    G3 6DF Glasgow
    British80233100002
    HARKIN, Mark James
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    Secrétaire
    5 Macnicol Park
    Kittochglen
    G74 4QE East Kilbride
    British42293490004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish35520610001
    MACKINTOSH, Iain Stewart
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    Administrateur
    90 Flat 2 Mayfield Road
    Newington
    EH9 2NJ Edinburgh
    British80118270001
    MACLEOD, Alan Donald Ewen
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    12 Violet Terrace
    EH11 1NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107116780001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 03 févr. 2006
    Livré le 17 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property now or in the future belonging to it and located in england or wales (see attached schedule) including fixed and floating charges.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 03 févr. 2006
    Livré le 16 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental debenture
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 14 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 14 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of accession
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 14 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over freehold land at 73-75 the strand, london NGL408757.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 14 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 mai 2002
    Livré le 29 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brèves mentions
    Subjects known as the bargarren centre, barrhill road, erskine (title number REN34783).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 mai 2002
    Livré le 29 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brèves mentions
    Subjects known as 6/14 church street and 6 baron taylor's street, inverness together with buildings and erections thereon and right, title and interest.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 mai 2002
    Livré le 29 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brèves mentions
    Subjects known as 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 mai 2002
    Livré le 29 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the charge, the facility agreements and any finance document
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease over subjects known as 158-204 main street, barrhead.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brèves mentions
    Gross rental income over 22 and 24 cambridge street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brèves mentions
    The gross rental income over the tenant's interest in 158-204 main street, barrhead.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brèves mentions
    The gross rental income over 6/14A church street and 6 baron taylor's street, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under this assignation, each of the facility agreements and each other finance document
    Brèves mentions
    The gross rental income over the barrangate centre, barhill road, erskine.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)

    STOCKLAND VENTURES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 sept. 2013Dissolved on
    02 août 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    practitioner
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0