PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED

PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPPT (GENERAL PARTNER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC226586
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    107 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE PRIVATE PROPERTY FUND (GENERAL PARTNER) LIMITED18 mars 200218 mars 2002
    THE PRIVATE PROPERTY FUND LIMITED16 janv. 200216 janv. 2002
    TM 1175 LIMITED24 déc. 200124 déc. 2001

    Quels sont les derniers comptes de PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2016

    État du capital au 18 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Summers Hunter le 01 janv. 2016

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 17 Rutland Street Edinburgh Midlothian EH1 2AE à 107 George Street Edinburgh EH2 3ES le 03 mars 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2014

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2015

    État du capital au 19 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Henry Charles Abram le 04 sept. 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michelle Fairfax le 28 févr. 2014

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2014 au 31 juil. 2014

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    4 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 4

    5 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 15

    5 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 12

    5 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 janv. 2014

    État du capital au 16 janv. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Summers Hunter le 13 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    28 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    27 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABRAM, Henry Charles
    India Street
    EH3 6HD Edinburgh
    56/4
    Scotland
    Secrétaire
    India Street
    EH3 6HD Edinburgh
    56/4
    Scotland
    British55822200001
    FAIRFAX, Michelle
    Mindrum Estate
    TD12 4QN Mindrum
    Mindrum
    Northumberland
    United Kingdom
    Administrateur
    Mindrum Estate
    TD12 4QN Mindrum
    Mindrum
    Northumberland
    United Kingdom
    EnglandBritish200834240001
    HAMILTON, Graham Robert
    18 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    18 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish120307930001
    HUNTER, Mark Summers
    Church Hill
    Chatton
    NE66 5PY Alnwick
    The Coach House
    Northumberland
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Chatton
    NE66 5PY Alnwick
    The Coach House
    Northumberland
    United Kingdom
    EnglandBritish97276390002
    LEGGATE, Peter James Arthur
    Greenlawdean House
    Greenlaw
    TD10 6XP Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Greenlawdean House
    Greenlaw
    TD10 6XP Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritish624640004
    SCOTT PLUMMER, Patrick Joseph
    Mainhouse
    TD5 8AA Kelso
    Roxburghshire
    Administrateur
    Mainhouse
    TD5 8AA Kelso
    Roxburghshire
    United KingdomBritish295090001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    CLARKE, Michael Drummond
    Nether Stewarton
    Eddleston
    EH45 8PP Peebles
    Administrateur
    Nether Stewarton
    Eddleston
    EH45 8PP Peebles
    United KingdomBritish89140100001
    LEGGATE, Peter James Arthur
    Greenlawdean House
    Greenlaw
    TD10 6XP Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Greenlawdean House
    Greenlaw
    TD10 6XP Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritish624640004
    WINSKELL, Andrew Dane
    15 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    15 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British26564000001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    PPT (GENERAL PARTNER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 mai 2008
    Livré le 12 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property units 1.3A, 3B, 3C, 6 & 7 parkway close, sheffield SYK369374, SYK369371 and SYK369372.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge floating charge
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 13 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 16 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 16 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 12 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    950 the green capability green luton BD214978.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 juil. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 12 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side of priestly road, worsley manchester GM568007.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 12 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of nuffield road, st ives cambridge CB111013.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The freehold property known as knurr ag building, burrell road, st. Ives, cambridgeshire (title number CB111013).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 juil. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 09 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fetter lane, london title no.342266.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The leeasehold property known as wrightstock house, priestley road, wardley industrial estate, manchester (title number GM568007).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 2003
    Livré le 07 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Vanguard house, dewsbury road, leeds WYK561919 WYK733328 WYK465521 WYK224038 WYK562503.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 août 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 2003
    Livré le 28 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of all debt where debt shall have the same meaning as in the bank's commercial charge conditions
    Brèves mentions
    29 town square and 38 queensway, stevenage--title number HD341354.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 08 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property (land and buildings on the south side of manchester road, huddersfield--title number WYK574851); fixed charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 17 avr. 2008
    Standard security
    Créé le 28 nov. 2002
    Livré le 06 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond
    Brèves mentions
    The subjects known as cowlairs industrial estate, glasgow (title number GLA108242).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 27 nov. 2002
    Livré le 06 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 21 november 2002
    Brèves mentions
    The benefit of all rents and other sums payable under the leases over subjects known as cowlairs industrial estate, glasgow (title number GLA108242).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 11 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    950 the green,capability green,luton.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 oct. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 juil. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 07 août 2002
    Livré le 14 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14 st john street & 16 duke street, cardiff--title numbers WA388814 & WA408821.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 août 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 03 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    100 west regent street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 avr. 2002
    Livré le 23 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0