HEPBURN 30 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEPBURN 30 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC226724
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEPBURN 30 LIMITED ?

    • (7440) /

    Où se situe HEPBURN 30 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Hepburn Road
    Hillington Park
    G52 4RJ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEPBURN 30 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AGRIPA LIMITED11 févr. 200211 févr. 2002
    FLEXIADZ LIMITED07 janv. 200207 janv. 2002

    Quels sont les derniers comptes de HEPBURN 30 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour HEPBURN 30 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Certificat de changement de nom

    Company name changed agripa LIMITED\certificate issued on 15/10/09
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 oct. 2009

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de HEPBURN 30 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PITT, David Anthony
    27 Station Road
    PA10 2EJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    27 Station Road
    PA10 2EJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British119302590001
    SHEARER, Alexander Craig
    21 Hillview Crescent
    Uddingston
    G71 6DW Glasgow
    Secrétaire
    21 Hillview Crescent
    Uddingston
    G71 6DW Glasgow
    British35726100001
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    British49964620002
    BURNESS SOLICITORS
    242 West George Street
    G2 4QY Glasgow
    Secrétaire
    242 West George Street
    G2 4QY Glasgow
    77097820001
    ALLAN, Andrew
    730 Clarkston Road
    G44 3YR Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    730 Clarkston Road
    G44 3YR Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish99881860001
    CAULFIELD, John
    4 Rock Drive
    Kilbarchan
    PA10 2HF Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    4 Rock Drive
    Kilbarchan
    PA10 2HF Johnstone
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117860300001
    GRANT, Roseanne
    6 Kilmeny Terrace
    KA22 8DX Ardrossan
    Ayrshire
    Administrateur
    6 Kilmeny Terrace
    KA22 8DX Ardrossan
    Ayrshire
    British31103650001
    HENDRY, Mark David
    6 Greenlaw Gardens
    PA1 3EL Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    6 Greenlaw Gardens
    PA1 3EL Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish119302650001
    KING, Gregory Hugh Colin
    Whitecraigs House
    Ayr Road
    Whitecraigs
    Glasgow
    Administrateur
    Whitecraigs House
    Ayr Road
    Whitecraigs
    Glasgow
    British87206320001
    KYLE, James Andrew
    75 Drumlin Drive
    Milngavie
    G62 6NF Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    75 Drumlin Drive
    Milngavie
    G62 6NF Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish109067190001
    LUTTON, David John
    Flat 1/2
    318 Byres Road
    G12 8AW Glasgow
    Administrateur
    Flat 1/2
    318 Byres Road
    G12 8AW Glasgow
    British87206440001
    MACAULEY, David
    90 South Mains Road
    Milngavie
    G62 6DG Glasgow
    Administrateur
    90 South Mains Road
    Milngavie
    G62 6DG Glasgow
    British40081520002
    PITT, David Anthony
    27 Station Road
    PA10 2EJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    27 Station Road
    PA10 2EJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritish119302590001
    PITT, John Dunlop
    5 Carlaverock Road
    Newlands
    G43 2SA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Carlaverock Road
    Newlands
    G43 2SA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish121245270001
    REID, Hilary Anne Frances
    Kaimflat Farmhouse
    TD5 7QN Kelso
    Roxburghshire
    Administrateur
    Kaimflat Farmhouse
    TD5 7QN Kelso
    Roxburghshire
    ScotlandBritish103094260001
    SHEARER, Alexander Craig
    21 Hillview Crescent
    Uddingston
    G71 6DW Glasgow
    Administrateur
    21 Hillview Crescent
    Uddingston
    G71 6DW Glasgow
    United KingdomBritish35726100001
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish49964620002

    HEPBURN 30 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 01 oct. 2004
    Livré le 06 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 nov. 2003
    Livré le 25 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 sept. 2002
    Livré le 01 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 oct. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0