ANAGACH WOODS TRUST
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ANAGACH WOODS TRUST |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | SC227929 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ANAGACH WOODS TRUST ?
| Adresse du siège social | The Court House The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ANAGACH WOODS TRUST ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ANAGACH WOODS TRUST ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 mars 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ANAGACH WOODS TRUST ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Rebecca Louise Stanton en tant que directeur le 20 janv. 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Alyson Lydia Jane Price en tant qu'administrateur le 25 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Stefanie Lauer en tant qu'administrateur le 25 nov. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jim Beveridge en tant que directeur le 25 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Hamish Napier en tant que directeur le 25 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 17 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alice Elizabeth Fogg le 20 juil. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Linda Frances Coe le 28 juil. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Peter James Edwards en tant que directeur le 17 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Ian Derek Pratt en tant que secrétaire le 01 févr. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Matthew Robert Hawkins en tant qu'administrateur le 26 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Stephen Peter James Edwards en tant qu'administrateur le 26 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Hilary Elaine Swift en tant que directeur le 26 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Hilary Elaine Swift en tant qu'administrateur le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Steven Andrew Blow en tant qu'administrateur le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Ardconnel House Woodlands Terrace Grantown-on-Spey PH26 3JU Scotland à The Court House the Square Grantown-on-Spey PH26 3HF le 08 nov. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Rebecca Louise Stanton en tant qu'administrateur le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ian Derek Pratt en tant qu'administrateur le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Duncan Henry Grant en tant que directeur le 06 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Mike Causey en tant que directeur le 06 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Nicholas Rowan Baker en tant qu'administrateur le 14 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Alice Elizabeth Fogg en tant qu'administrateur le 14 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de ANAGACH WOODS TRUST ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRATT, Ian Derek | Secrétaire | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | 332342530001 | |||||||
| BAKER, Nicholas Rowan | Administrateur | Grant Road PH26 3LD Grantown-On-Spey Ardenbeg Scotland | Scotland | British | 314920060001 | |||||
| BLOW, Steven Andrew | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 315699830001 | |||||
| COE, Linda Frances | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | English | 245152170002 | |||||
| FOGG, Alice Elizabeth | Administrateur | Insh PH21 1NU Kingussie Mowdiebank Scotland | Scotland | British | 314599670002 | |||||
| HAWKINS, Matthew Robert | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 244736230001 | |||||
| LAUER, Stefanie | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 342920660001 | |||||
| MELTON, Andrew John, Dr | Administrateur | Woodside Avenue PH26 3JR Grantown-On-Spey Highlea Scotland | Scotland | British | 207561520001 | |||||
| PRATT, Ian Derek | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 315681700001 | |||||
| PRICE, Alyson Lydia Jane | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey Court House Scotland | Scotland | Welsh | 343070510001 | |||||
| ROBERTSON, Andrew | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 294408940001 | |||||
| BAIRD, William David | Secrétaire | Pineview Mossie Road PH26 3HW Grantown On Spey Morayshire | British | 112952110001 | ||||||
| CLARK, Louise | Secrétaire | 3 Seabank Gardens IV12 4RR Nairn | British | 8799470005 | ||||||
| FERRIS, Michael Ian | Secrétaire désigné | 12 Springfield Road HS1 2PT Stornoway Isle Of Lewis | British | 900023140001 | ||||||
| FORD, Andrew John | Secrétaire | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | 244931070001 | |||||||
| RODGERS, Fiona Mary | Secrétaire | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | 176483080001 | |||||||
| ARCHIBALD, Daniel Carmichael | Administrateur | Strathspey Drive PH26 3EY Grantown-On-Spey 28 Moray | United Kingdom | British | 135124730001 | |||||
| BAIRD, Pamela Jeanne | Administrateur | Pineview Mossie Road PH26 3HW Grantown-On-Spey Morayshire | United Kingdom | British | 115364180001 | |||||
| BEVERIDGE, Jim | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | Scotland | British | 294409330001 | |||||
| BRUCE, John Edward | Administrateur | Lodge Of Finlarig Dulnain Bridge PH26 3NU Grantown On Spey Morayshire | United Kingdom | British | 253320002 | |||||
| CALDWELL, Marcus | Administrateur | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 294408720001 | |||||
| CAUSEY, Mike | Administrateur | Woodlands Terrace PH26 3JU Grantown-On-Spey Ardconnel House Scotland | Scotland | British | 294404250001 | |||||
| CLARK, Andy | Administrateur | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 173274420001 | |||||
| DUNLOP, Basil Matthew Stuart | Administrateur | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 27235600001 | |||||
| DUNLOP, Basil Matthew Stuart | Administrateur | Ben A'An Lynemacgregor PH26 3PR Grantown-On-Spey Moray | Scotland | British | 27235600001 | |||||
| EDWARDS, Stephen Peter James | Administrateur | The Square PH26 3HF Grantown-On-Spey The Court House Scotland | United Kingdom | British | 329869630001 | |||||
| ELDER, David Joe Watson | Administrateur | Roseburn, 19 Seafield Court PH26 3LE Grantown-On-Spey Morayshire | United Kingdom | British | 93397560001 | |||||
| FISHER, Alan Edwin Stanley | Administrateur | Woodside Avenue PH26 3JR Grantown-On-Spey Kinrara Moray | Uk | British | 128528360001 | |||||
| FORD, Andrew John | Administrateur | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 207559780001 | |||||
| GRANT, Duncan Henry | Administrateur | Woodlands Terrace PH26 3JU Grantown-On-Spey Ardconnel House Scotland | Scotland | British | 88000180001 | |||||
| GRANT, Duncan Henry | Administrateur | The Neuk Grant Road PH26 3LA Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 88000180001 | |||||
| HARROLD, Edward | Administrateur | Woodlands Terrace PH26 3JU Grantown-On-Spey Ardconnel House Scotland | Scotland | British | 294522740001 | |||||
| HART, Ritchie John | Administrateur | South Street PH26 3JA Grantown-On-Spey 6 Strathspey Lodges Moray United Kingdom | United Kingdom | British | 160213960001 | |||||
| HART, Ritchie John | Administrateur | 19 Castle Road East PH26 3HS Grantown On Spey Moray | British | 88000790001 | ||||||
| HAWKINS, Matthew Robert | Administrateur | The Townhouse The Square PH26 3HF Grantown On Spey Highland | Scotland | British | 244736230001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ANAGACH WOODS TRUST ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 11 févr. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0