ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED

ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANNFIELD INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC228989
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Où se situe ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Maclay Murray & Spens Quartermile One
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KILMARTIN INVESTMENTS LIMITED02 avr. 200202 avr. 2002
    KILMARTIN SECURITIES LIMITED11 mars 200211 mars 2002

    Quels sont les derniers comptes de ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)
    A11SXL8I

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 juin 2011

    LRESSP

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2010 au 31 mars 2011

    1 pagesAA01
    XUAXCUSW

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2011

    État du capital au 16 mars 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X213LSHX

    Nomination de Mrs Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    XWQXTS23

    Cessation de la nomination de Susan Groat en tant que directeur

    2 pagesTM01
    SWNNVRUE

    legacy

    3 pagesMG02s
    SWONWRQC

    legacy

    3 pagesMG03s
    SWONGRQW

    legacy

    3 pagesMG02s
    SWONVRQB

    legacy

    3 pagesMG02s
    SWONNRQ3

    legacy

    3 pagesMG02s
    SWONURQA

    legacy

    3 pagesMG03s
    SWONFRQV

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    15 pagesAA
    S4JVXL6Y

    Changement d'adresse du siège social de 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH le 03 juin 2010

    2 pagesAD01
    S5254KJB

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    XGI63J4R

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Gordon Bennet en tant que directeur

    2 pagesTM01
    S899GICS

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04
    SAQFOGLW

    Nomination de Gordon Iain Bennet en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    SAQFNGLV

    Nomination de Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    SAQFMGLU

    Cessation de la nomination de Robert Wotherspoon en tant que directeur

    2 pagesTM01
    SAQFLGLT

    Cessation de la nomination de Neil Mcguinness en tant que directeur

    2 pagesTM01
    SAQFKGLS

    legacy

    5 pages410(Scot)
    SGNFQCQ2

    Qui sont les dirigeants de ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GROAT, Susan Elizabeth
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    ScotlandBritishProperty Developer88980540001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    BritishSolicitor562500001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    Administrateur
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant60009740002
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritishProperty Developer88980540001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    ScotlandBritishFinance Director83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Administrateur
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    BritishProperty97869190001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Surveyor161858620001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 19 août 2009
    Livré le 26 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8 to 14 young street lane north & garage at 24 young street lane north, edinburgh MID103259.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 août 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 16 avr. 2008
    Livré le 24 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All obligations undertaken to the creditor in terms of a clawback agreement dated 04/04/08
    Brèves mentions
    4 storey tenement on the west side of rose street lane north, edinburgh located to the rear of 29/31 frederick street, edinburgh MID115164.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 31 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 18 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    114 princes street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    116 princes street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 22 march 2006
    Brèves mentions
    The ground and basement floors known as 162 union street, aberdeen (title number ABN8016).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.015 and 3.069 acres at greenwell road, east tullos industrial estate, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 2006
    Livré le 15 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The leasehold property known as land and buildings at parkhouse east industrial estate newcastle under lyme.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    292/294 st vincent street and 125/127 pitt street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 16 sept. 2005
    Livré le 27 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at the junction of the A19 and A689 wynyard hall, billingham, stockton on tees.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 juil. 2005
    Livré le 18 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects comprising 45-57 high street, leven (title number FFE39252).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 10 juin 2005
    Livré le 17 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all the freehold property known as spring lane, andover, hampshire (title number HP564907); fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 castle street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 05 avr. 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over leasehold property known as land and buildings on the north side of sanderson street, newcastle upon tyne TY245732.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4/8 frances street, stornoway.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    54 & 56 princes street, port glasgow REN70658.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    40 main street & 7 mill street, rutherglen LAN113712.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    98,100 & 102 dockhead street, saltcoats AYR23986.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    34 glaisnock street, cumnock AYR17072.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 tryst road & 48 king street, stenhousemuir, larbert STG19470.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    102 argyll street, dunoon ARG5229.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 avr. 2004
    Livré le 07 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 15 march 2004
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 22-24 cambridge street, glasgow (title number gla 47546).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 mars 2004
    Livré le 01 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land north east of nunnery drive, sheffield SYK266684.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 août 2003
    Livré le 06 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 28 july 2003
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 1 and 2 pitt terrace, stirling (title number STG7997).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 août 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 mai 2003
    Livré le 22 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 28 april 2003
    Brèves mentions
    The subjects comprising the shop units on the ground and basement floors (and mezzanine level between) forming 178, 180, 182 and 186 trongate, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    ANNFIELD INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2012Dissolved on
    15 juin 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0