THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED

THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC229277
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dundas House
    Westfield Park
    EH22 3FB Eskbank
    Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PBL 195 LIMITED18 mars 200218 mars 2002

    Quels sont les derniers comptes de THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2010

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2010

    État du capital au 06 mai 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ccw Secretaries Limited le 01 mars 2010

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées du secrétaire Pagan Secretaries Limited le 01 mars 2010

    2 pagesCH04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2009

    29 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2008

    23 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2007

    24 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2006

    20 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2005

    20 pagesAA

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CCW SECRETARIES LIMITED
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Crescent House
    Fife
    United Kingdom
    Secrétaire
    Carnegie Campus
    KY11 8GR Dunfermline
    Crescent House
    Fife
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC182936
    63577400019
    GAMMELL, Geraldine Elizabeth
    14 Lynedoch Place
    EH3 7PY Edinburgh
    Administrateur
    14 Lynedoch Place
    EH3 7PY Edinburgh
    ScotlandBritish107808620002
    SEALEY, Barry Edward
    4 Castlelaw Road
    EH13 0DN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Castlelaw Road
    EH13 0DN Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish23790001
    WILKIE, James Mills
    1a Tantallon Terrace
    EH39 4LE North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    1a Tantallon Terrace
    EH39 4LE North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish825830002
    CLARKE, John Bernard
    Kingsknowe
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    Administrateur désigné
    Kingsknowe
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    ScotlandBritish900000100001

    THE DUNDAS COMMERCIAL PROPERTY (GENERAL PARTNER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of rents
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 12 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rental income over property at church court, morley WYK296795.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 2005
    Livré le 12 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings at church court, morley, west yorkshire WYK296795.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 29 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 8, mickleton road, riverside park, middlesbrough (title number CE114938).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 29 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 29 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings lying on the east side of bowesfield lane, stockton on tees (title numbers CE94922, CE86162 and CE114254).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 29 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 août 2004
    Livré le 08 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Taygate trading estate, coldside road, dundee ANG5637.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West PLC
    Transactions
    • 08 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 30 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property at 159, 161 and 163 albert road, middlesborough--title number CE44164; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 24 mars 2004
    Livré le 05 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest in and to all rent over units 1 & 2 metro centre east business park, waterside drive, dunston, gateshead.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Legal mortgage
    Créé le 24 mars 2004
    Livré le 05 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1 & 2 metro centre east business par, waterside drive, dunston, gateshead.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 08 mars 2004
    Livré le 16 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the south east of riverside park road, riverside park industrial estate, middlesborough--title number CE116350.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 mars 2004
    Livré le 16 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the land and buildings lying to the south east of riverside park road, riverside park industrial estate, middlesborough--title number CE116350; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 07 nov. 2003
    Livré le 15 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the right, title and benefit and interest of the company in and to all the rent in respect of the property comprising the land on the south east side of herries road south, sheffield (title number SYK84860).
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 07 nov. 2003
    Livré le 15 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land on the south east side of herries road south, sheffield (title number SYK84860) and all buildings etc on the property; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 14 juil. 2003
    Livré le 15 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    29 high street, paisley, renfrewshire (title number REN97928).
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ivebridge house, market street, bradford, west yorkshire--title number WYK709625.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property known as ivebridge house, market street, bradford, west yorkshire; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 05 mars 2003
    Livré le 12 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the south east of riverside park road, riverside park industrial estate, middlesborough--title number CE117283.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 12 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 05 mars 2003
    Livré le 12 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the land lying to the south east of roverside park road, riverside park industrial estate, middlesborough--title number CE117283; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 12 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 04 mars 2003
    Livré le 08 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as 30 & 32 yarm road, stockton on tees--title number CE4427; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 08 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of rental assignment
    Créé le 04 mars 2003
    Livré le 08 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    30 & 32 yarm road, stockton on tees--title number CE4427.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 08 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 10 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63-87 highg street, 1A, 3, 7 & 9 whytescauseway and 2A whytehouse avenue, kirkcaldy--title number FFE9212.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 janv. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property known as mandale house, harbour walk, the highlight, hartlepoole marina, hartlepool--title number CE154529; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Rental assignment
    Créé le 30 janv. 2003
    Livré le 07 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mandale house, harbour walk, the highlight, hartlepoole marina, hartlepool--title number CE154529.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 29 janv. 2003
    Livré le 29 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 29 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0