CHRYSALIS LP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHRYSALIS LP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC229485
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHRYSALIS LP LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    2nd Floor 11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHRYSALIS GENERAL PARTNER LIMITED22 avr. 200222 avr. 2002
    MM&S (2863) LIMITED21 mars 200221 mars 2002

    Quels sont les derniers comptes de CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    48 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan Peter Doberman en tant qu'administrateur le 04 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nestor Augusto Castillo Borrero en tant que directeur le 04 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biif Corporate Services Limited le 01 juil. 2015

    1 pagesCH02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 avr. 2015

    État du capital au 20 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,488,002
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Nomination de Mr Nestor Augusto Castillo Borrero en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Forrest en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Infrastructure Managers Ltd 2Nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF* le 27 mai 2014

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Forrest le 21 mai 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2014

    État du capital au 14 avr. 2014

    • Capital: GBP 1,488,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Forrest le 11 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Forrest le 09 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biff Corporate Services Limited le 04 sept. 2012

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biff Corporate Services Limited le 04 sept. 2012

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Infrastructure Managers Limited le 26 févr. 2013

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biff Corporate Services Limited le 04 sept. 2012

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Infrastructure Managers Limited le 22 févr. 2013

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Nomination de Michael Forrest en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CHRYSALIS LP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05372427
    128530180002
    DOBERMAN, Jonathan Peter
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    Administrateur
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish201234400001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06793845
    138240210001
    SMEATON, Robin Campbell
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Scottish2584040001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritish138241960001
    FORREST, Michael
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish169634490002
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Administrateur
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Administrateur
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    Administrateur
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    United KingdomBritish85320540001
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Administrateur
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Administrateur
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    CHRYSALIS LP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 28 juil. 2011
    Livré le 16 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2011
    Livré le 11 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Supplemental deed to debenture
    Créé le 13 mai 2009
    Livré le 22 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 28 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges and floating charge over all assets - see form 410 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 28 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Share pledge, assignation and floating charge over all assets - see form 410 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 19 déc. 2007
    Livré le 28 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Confirmation to debenture including legal mortgage, fixed charges and floating charge over all assets - see form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 22 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 22 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 22 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 04 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See form 410 for details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 04 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charge over assets, floating charge over same - see form 410 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental deed to debenture
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed charge over the accounts, monies standing credit to the account, the receivables etc. see form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 2005
    Livré le 07 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 nov. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 déc. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 janv. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 nov. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 déc. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    Floating charge
    Créé le 02 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 janv. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 nov. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 déc. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0