COLERIDGE (NO. 5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLERIDGE (NO. 5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC230325
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    15 pagesLIQ13(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 janv. 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC2303250020 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2303250021 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2303250022 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2017

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 24 févr. 2017

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Valad Secretarial Services Limited le 24 févr. 2017

    1 pagesCH04

    Nomination de Mr James Edward Maddy en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2016

    26 pagesAA

    Inscription de la charge SC2303250022, créée le 16 déc. 2016

    71 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2303250021, créée le 16 déc. 2016

    26 pagesMR01

    Inscription de la charge SC2303250020, créée le 16 déc. 2016

    21 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300003
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Secrétaire
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    British40585290002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    BLAIN, Andrew John
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Administrateur
    60 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    ScotlandBritish40585290002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Claire Michelle
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    Administrateur
    Flat 3f2
    2 Brunswick Place
    EH7 5HP Edinburgh
    British81040630001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House, 20
    North Yorkshire
    Administrateur
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House, 20
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COLERIDGE (NO. 5) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Philip Lawrence Turpin
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    17 mai 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Jersey
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Robin Baird
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    17 mai 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Jersey
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Msms Nominee 1 Limited
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    England
    16 déc. 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    England
    Oui
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement09282363
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COLERIDGE (NO. 5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 déc. 2016
    Livré le 23 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold tenure of the land and buildings known as london court, 39 london road, reigate, RH2 9AQ registered in the land registry with title numbers SY243432 and SY712318.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 déc. 2016
    Livré le 23 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 déc. 2016
    Livré le 23 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 02 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 07 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession agreement and change
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interest in the existing shares and related rights.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as 5 bedford park, croydon, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as 111 chertsey road, woking, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as shell house, 77 clarendon road, watford; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as cedar house, 39 london road, reigate, surrey; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all freehold property known as charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 111 chertsey road, woking, surrey; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in units 1 and 2 sterling court, welwyn garden city, hertfordshire; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in 5 bedford park, croydon, surrey; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 in charter house, 462 avebury boulevard, milton keynes; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreeement dated 16 april 2002 over cedar house, 39 london road, reigate, surrey; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 18 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over its right, title, benefit and interest under the agreement dated 16 april 2002 over shell house, 77 clarendon road, watford; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    COLERIDGE (NO. 5) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 janv. 2019Commencement of winding up
    16 janv. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0