COLERIDGE (NO.8) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLERIDGE (NO.8) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC232124
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLERIDGE (NO.8) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe COLERIDGE (NO.8) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (NO.8) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (NO.8) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    44 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 22 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 26 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 28 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 27 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 mars 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fraser James Kennedy en tant que directeur le 14 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 14 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2015

    État du capital au 29 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    24 pagesAA

    Comptes établis au 30 juin 2013

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mai 2014

    État du capital au 30 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (NO.8) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300002
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Secrétaire désigné
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    British900023700001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Administrateur désigné
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    British900023690001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    FOWLIE, Frank Alexander
    Flat 1/2, 18 Woodburn Terrace
    EH10 4SH Edinburgh
    Administrateur
    Flat 1/2, 18 Woodburn Terrace
    EH10 4SH Edinburgh
    British81464680001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AG Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AG Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (NO.8) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share pledge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 25 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 03 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the security assets as security for the secured sums. (Please see form).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 03 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the security assets as security for the secured sums please see form.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 02 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 07 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 07 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the units and related rights (security assets).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession agreement and charge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interest in the existing shares and the related rights.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 18 juin 2003
    Livré le 28 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all the freehold property known as land at 110-113 tottenham court road, london (title number 226325); fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 10 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The market place, high street, blackwood, gwent. See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as land at arundel court, furnival street, sheffield, south yorkshire--title number SYK439410; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as 147-149 london road, east grinstead--title number WSX18176; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as 2010 meriden business park, birmingham road, allesley, coventry; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as 49/53 london street, reading--title number BK253666; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the land known as 27 & 29 cathedral road, cardiff--title numbers WA959576 and WA959577; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 01 nov. 2002
    Livré le 11 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property known as 38 stepney street, llanelli; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 oct. 2002
    Livré le 23 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the freehold property known as 130 and 132 above bar street, southampton; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 110-113 tottenham court road, london; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at arundel court, furnival street, sheffield, south yorkshire; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 2010 meriden business park, birmingham road, allesley, coventry; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at 49/53 london street, reading; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in the land and buildings at 147 and 149 london road, east grinstead; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over contract for sale
    Créé le 27 juin 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First equitable charge over the right, title, benefit and interest under the agreement dated 27 june 2002 in land and buildings at market place, blackwood, gwent; first fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    COLERIDGE (NO.8) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mars 2016Commencement of winding up
    24 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0