ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED

ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC232238
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2016

    État du capital au 09 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Roscoe Capital Ltd 9-10 st. Andrew Square Edinburgh EH2 2AF Scotland à 125 6th Floor Princes Street Edinburgh EH2 4AD

    1 pagesAD02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 05 avr. 2015

    11 pagesAA

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 juin 2015

    État du capital au 26 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 30 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 28 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 22 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 29 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDERSON, Dickson Brown
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Administrateur
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    ScotlandBritishHead Of Investments7351410004
    MCMYN, Neil Armstrong
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Administrateur
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant126304800001
    WEBBER, John David
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Administrateur
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    United KingdomBritishDirector41493670002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    STANWORTH, William John
    Highfield House
    194 Main Street
    EH37 5SG Pathhead
    Midlothian
    Secrétaire
    Highfield House
    194 Main Street
    EH37 5SG Pathhead
    Midlothian
    British41736370002
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    BROOK, Robert William Middleton
    Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    22
    Midlothian
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    22
    Midlothian
    United KingdomBritishNone149783170001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritishChartered Accountant462890002
    HEDDERWICK, Alexander Mark
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    Administrateur
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    United KingdomBritishDirector89989960001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishManaging Director71043680001
    MORGAN, Harry James
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    Administrateur
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    25
    Scotland
    United KingdomBritishFund Manager103806200002
    MORRIS, Philip Taylor
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    BritishCompany Director35386590001
    MULLIGAN, Andrew Kyle
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishFinance Director161603300002
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Accountant104673590001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    ADAM & COMPANY GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of rents
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as dundyvan industrial estate, coatbridge lan 102640.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as auchinraith industrial estate, blantyre lan 22075.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as new albion industrial estate, glasgow gla 108239.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 10 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Auchinraith industrial estate, blantyre LAN22075.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 10 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 10 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Dundyvan industrial estate, coatbridge LAN102640.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 10 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 10 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    New albion industrial estate, glasgow GLA108239.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 10 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 10 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Starlaw business park, livingston WLN24067.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 10 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 23 nov. 2004
    Livré le 26 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due to any finance party under each finance document
    Brèves mentions
    First legal mortgage over unit 2A stephenson road, stephenson industrial estate, washington, tyne & wear (title number TY316197).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 26 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 29 sept. 2004
    Livré le 07 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed charge over freehold land south of nelson street and hulland street, derby DY342778.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 11 août 2004
    Livré le 17 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities under each finance document
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all that freehold land and buildings known as land on the south east side of prince charlie street, oldham (title number GM528355).
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 17 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 22 janv. 2004
    Livré le 30 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1,2 & 3 whitley road retail park, whitley road, longbenton, newcastle TY284972 TY183940 TY300974 TY176297 TY188764.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 30 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 oct. 2003
    Livré le 03 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (One) subjects comprising (a) area of ground on the south side of cunningham road and (b) area of ground on the east side of munro road, springkerse industrial estate, stirling--title number STG17431 (two) subjects known as unit 11, 20 munro road, stirling--title number STG25280 (three) tenant's interest in the lease under title number STG17266.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 03 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 09 oct. 2003
    Livré le 20 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interest over blocks 1-5 springkerse industrial estate, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 20 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 22 sept. 2003
    Livré le 06 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Retail warehouse site at whistleberryroad, hamilton LAN106225.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee
    Transactions
    • 06 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 18 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rental income over focus diy unit, whistleberry road, blantyre, dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 26 août 2003
    Livré le 09 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Marina court, castel street, kingston upon hull HS188460.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 09 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 17 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement dated 20 december 2002 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brèves mentions
    0.100 hectares of ground comprising the office block or building with car parking pertaining thereto known as and forming cromarty house, 67-72 regent quay, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 15 juil. 2003
    Livré le 18 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    Right, title and interest in and to the rental income.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 18 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 07 juil. 2003
    Livré le 09 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, titlr and interst in and to the rental income as security for the secured liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 09 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 2003
    Livré le 15 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to a credit agreement dated 20 december 2002 and each finance document
    Brèves mentions
    The subjects known as the academy centre, belmont street, aberdeen (title number ABN5021).
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 15 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Kingsway shopping centre, frome, somerset.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    31-34 high street, tewkesbury.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    80-84(Even) town centre, the common, hatfield.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental security agreement
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    79-85(Odd numbers) humberston gate, leicester title no.LT339649.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under each finance document
    Brèves mentions
    The scheduled securities and all rights derived from the shares.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0