TOUCH BIONICS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TOUCH BIONICS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC232512 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOUCH BIONICS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Integration House Alba Business Park EH54 7EG Livingston West Lothian Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOUCH BIONICS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TOUCH BIONICS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TOUCH BIONICS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sveinn Solvason le 11 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tomas Eiriksson en tant que directeur le 08 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Guðný Arna Sveinsdóttir en tant qu'administrateur le 08 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 30 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 30 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Ossur Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 juin 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des détails de Ossur Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov. 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 32 pages | AA | ||||||||||
Comptes modifiés avec exemption d'audit pour une filiale jusqu'au 31 déc. 2020 | 29 pages | AAMD | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Statuts | 34 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Theodorus Joseph Lambertus Wilhelmus Van Poorten en tant que directeur le 01 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jon Sigurosson en tant que directeur le 01 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Gill en tant que directeur le 01 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Tomas Eiriksson en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOUCH BIONICS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLVASON, Sveinn Logi | Administrateur | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 207109890002 | |||||||||||||
| SVEINSDÓTTIR, Guðný Arna | Administrateur | 109 Reykjavík Akrasel 16 Iceland | Iceland | Icelandic | 334554540001 | |||||||||||||
| KING, Susan | Secrétaire | 8 Buckstone Row EH10 6TP Edinburgh | British | 82365770001 | ||||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Secrétaire | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | British | 37456310002 | ||||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Secrétaire | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | 191434580001 | |||||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Secrétaire | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | British | 131537440001 | ||||||||||||||
| BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 Scotland |
| 79799970001 | ||||||||||||||
| BURNESS LLP | Secrétaire | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 99448920001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire désigné | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||||||||||
| ALLAN, Sandy | Administrateur | c/o Scottish Health Innovations Ltd Vincent Street G2 5SG Glasgow 206 Scotland | United Kingdom | British | 131641960001 | |||||||||||||
| BORTHWICK, George Cooper, Professor | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 9509780001 | |||||||||||||
| BROWN, John, Dr | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 190745120001 | |||||||||||||
| CADENHEAD, Lynne | Administrateur | 49 Castle Gate G71 7HU Bothwell | Scotland | British | 87524030001 | |||||||||||||
| EIRIKSSON, Tomas | Administrateur | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | Iceland | Icelandic | 294989330001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| FORD, Mark William | Administrateur | Gordon Road 45335 Jamestown 1800 Greene County Usa | Usa | American | 138542690001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Administrateur | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILL, Hugh | Administrateur | 22 Redhurst Way Gleniffer Gate PA2 8PY Paisley | United Kingdom | British | 79680760001 | |||||||||||||
| GILLIES, Crawford Scott | Administrateur | 12 Heriot Row EH3 6HP Edinburgh Midlothian | British | 42352800002 | ||||||||||||||
| GOW, David James | Administrateur | 33 Fox Spring Rise EH10 6NE Edinburgh Midlothian | British | 75967370001 | ||||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| GRANT, John Albert Martin | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | England | British | 55161940001 | |||||||||||||
| MACDONALD, Cameron Mackay | Administrateur | 10 Paxton Close MK46 5PR Olney Buckinghamshire | England | British | 56171470001 | |||||||||||||
| MACKEAN, Robert Mackintosh | Administrateur | 10a Dick Place EH9 2JL Edinburgh | Scotland | British | 37456310002 | |||||||||||||
| MCBEATH, David George | Administrateur | Carwinshoch Carrick Riggs KA7 4LB Ayr | British | 68030880002 | ||||||||||||||
| MCGILL, Colin Scott | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | United Kingdom | British | 663080001 | |||||||||||||
| MCGREGOR, Jill Amanda | Administrateur | Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston 3 Ashwood Court United Kingdom | United Kingdom | British | 160432920002 | |||||||||||||
| MEAD, Stuart Edgar | Administrateur | 2 Bury Farm Potter Row HP16 9LU Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 98961660001 | |||||||||||||
| MISHRA, Gaurav | Administrateur | Whitacres G53 7LJ Glasgow 56 Lanarkshire Uk | Indian | 134290810001 | ||||||||||||||
| NEWMAN, Philip James | Administrateur | 74 Lye Green Road HP5 3NB Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13755770004 | |||||||||||||
| PASSERO, Thomas | Administrateur | Kelly Road, PO BOX 82 NY 12740 Grahamsville 47 New York United States | Other | 131854840001 | ||||||||||||||
| PATTULLO, Robert Michael | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 54596190001 | |||||||||||||
| REYNARD, Martin, Dr | Administrateur | Station Road EH27 8BJ Kirknewton The Old Schoolhouse West Lothian Uk | United Kingdom | British | 131537440001 | |||||||||||||
| SIGUROSSON, Jon | Administrateur | Alba Business Park EH54 7EG Livingston Integration House West Lothian Scotland | United States | Icelandic | 207109850001 | |||||||||||||
| STEVENS, Ian Herbert | Administrateur | 3 Ashwood Court Oakbank Park Way EH53 0TH Livingston West Lothian | Scotland | British | 148952800001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOUCH BIONICS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossur Uk Holding Limited | 11 avr. 2016 | Hamilton Road SK1 2AE Stockport Unit No. 1 S. Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0