INNOSCOT HEALTH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INNOSCOT HEALTH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC236303 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| Adresse du siège social | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 17 sept. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 03 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Seshadri Srini Vasan le 20 août 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Professor Julie Brittenden en tant qu'administrateur le 12 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Seshadri Srini Vasan le 20 août 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Chloe Cowan en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Statuts | 25 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Julie Brittenden en tant que directeur le 12 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Chloe Cowan en tant qu'administrateur le 12 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gordon James en tant que directeur le 04 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Professor Colin John Fleming en tant qu'administrateur le 19 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Russell Petty en tant que directeur le 19 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Douglas Griffin en tant que directeur le 27 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Morgan en tant que directeur le 19 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Seshadri Srini Vasan le 22 avr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Professor Russell Petty le 22 avr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gordon James le 22 avr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Professor Seshadri Srini Vasan en tant qu'administrateur le 06 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Margaret Eleanor Cruickshank en tant que directeur le 06 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Graeme Boyle en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Netherpark Avenue G44 3XW Glasgow 26 Scotland |
| 238440100001 | ||||||||||
| BRITTENDEN, Julie, Professor | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 United Kingdom | Scotland | British | 191969700002 | |||||||||
| FLEMING, Colin John, Professor | Administrateur | Ninewells Hospital DD1 9SY Dundee Department Of Dermatology Scotland | Scotland | British | 165580410001 | |||||||||
| VASAN, Seshadri Srini, Professor | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British,Australian | 337585230001 | |||||||||
| WATSON, Graham Forgie | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | United Kingdom | British | 211482080002 | |||||||||
| PALMER, Graeme Thomas | Secrétaire | 22 Oban Drive G20 6AF Glasgow Lanarkshire | British | 67683800001 | ||||||||||
| RICE, Lauren | Secrétaire | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire | 205407820001 | |||||||||||
| WALKER, Fiona | Secrétaire | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire Scotland | British | 85395840005 | ||||||||||
| ALLAN, Alexander, Dr | Administrateur | c/o Scottish Health Innovations Limited 5th Floor 46 Bath Street G2 1HJ Glasgow Tara House Scotland | Scotland | British | 22154200003 | |||||||||
| BELCH, Jill Jannette Freda, Professor | Administrateur | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire Scotland | Scotland | British | 163985450001 | |||||||||
| BOYLE, William Graeme | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 110013560001 | |||||||||
| BRITTENDEN, Julie, Professor | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 191969700002 | |||||||||
| BROWN, Julia Mary | Administrateur | c/o Scottish Health Innovations Limited 5th Floor 46 Bath Street G2 1HJ Glasgow Tara House Scotland | Scotland | Scottish | 65822270002 | |||||||||
| COWAN, Chloe | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 United Kingdom | Scotland | British | 335061060001 | |||||||||
| CRUICKSHANK, Margaret Eleanor, Professor | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 214168600001 | |||||||||
| DAVIES, Sara Joy | Administrateur | Regent Road EH1 3DG Edinburgh St Andrew’S House Scotland | Scotland | British | 163985550001 | |||||||||
| FINLAYSON, Sandy | Administrateur | c/o Scottish Health Innovations Limited 5th Floor 46 Bath Street G2 1HJ Glasgow Tara House Scotland | United Kingdom | British | 117556630001 | |||||||||
| FOWLIE, Andrew | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 49559830002 | |||||||||
| GARDNER, Jann Catherine Susan | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 267997140001 | |||||||||
| GEMMELL, Elaine | Administrateur | Great Western Road Gartnavel Royal Hospital G12 0XH Glasgow West House Scotland | Scotland | British | 163459850002 | |||||||||
| GEORGE, Jacob, Professor | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | Malaysian | 267997150002 | |||||||||
| GRIFFIN, David Douglas | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 126401830001 | |||||||||
| HENDERSON, Andrew | Administrateur | Apex House 99 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 110887480001 | |||||||||
| JAMES, Gordon | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 307349440001 | |||||||||
| KAY, Nicola Kate Ingouville | Administrateur | 3f2 3 Brandon Terrace EH3 5EA Edinburgh Midlothian | British | 84080600002 | ||||||||||
| KIST, Heleen Francoise | Administrateur | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire Scotland | Scotland | Dutch | 83239620001 | |||||||||
| MACDONALD, Cameron Mackay | Administrateur | 10 Paxton Close MK46 5PR Olney Buckinghamshire | England | British | 56171470001 | |||||||||
| MACNEIL, Ruaraidh Anthony | Administrateur | 76 Cradlehall Park Westhill IV2 5DA Inverness Invernesshire | British | 84080610001 | ||||||||||
| MCBEATH, David George | Administrateur | Carwinshoch Carrick Riggs KA7 4LB Ayr | British | 68030880002 | ||||||||||
| MCKELLAR, Keith Alexander James | Administrateur | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire Scotland | Scotland | British | 60974260002 | |||||||||
| MITCHELL, Eleanor Moira, Dr | Administrateur | St Vincent Street G2 5SG Glasgow 206 | Scotland | British | 263571300001 | |||||||||
| MORGAN, Colin | Administrateur | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | 114337360004 | |||||||||
| MUNRO, Alexander, Professor | Administrateur | 23 Eriskay Road IV2 3LX Inverness Highland | Scotland | British | 94945070001 | |||||||||
| NATHWANI, Dilip, Professor | Administrateur | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire | Scotland | British | 96676770001 | |||||||||
| PACKARD, Chris | Administrateur | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 163985610001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INNOSCOT HEALTH LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Jubilee National Hospital | 06 avr. 2016 | Level Four East Agamemnon Street G81 4DY Clydebank Golden Jubilee National Hospital Dunbartonshire United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Nhs Tayside | 06 avr. 2016 | Ninewells Hospital DD1 9SY Dundee Level 10, Ninewells Hospital Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Chief Scientist Office | 06 avr. 2016 | Regent Road EH1 3DG Edinburgh St. Andrew's House Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0