HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED

HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC236593
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    28 Stafford Street
    Edinburgh
    EH3 7BD
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED20 mai 200420 mai 2004
    MORNINGSIDE HOMES (FOX COVERT) LIMITED31 oct. 200231 oct. 2002
    LEDGE 676 LIMITED10 sept. 200210 sept. 2002

    Quels sont les derniers comptes de HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed kenmore homes (fox covert) limit ed\certificate issued on 09/02/08
    2 pagesCERTNM

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    9 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Anne Elizabeth
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    Secrétaire
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    British74781620001
    MEGAN, Michael Francis
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    Administrateur
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    EnglandIrish46067860003
    REID, Andrew Richard
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish145630001
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    DAMES, Kevin John
    151 Bruntsfield Place
    EH10 4EB Edinburgh
    Administrateur
    151 Bruntsfield Place
    EH10 4EB Edinburgh
    British62968700001
    DUFFIN, James
    13 Dean Park Court
    KY2 6XN Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    13 Dean Park Court
    KY2 6XN Kirkcaldy
    Fife
    British82920550001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    PRICHARD, Kim Alan
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    British72744060002
    THOMSON, William George Ritchie
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    Administrateur
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    ScotlandBritish72331280002
    WILKINSON, Charles George
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritish47095110003
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Administrateur désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900023980001

    HIGHMORE HOMES (FOX COVERT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 14 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8 fox covert avenue, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 févr. 2005
    Livré le 01 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mars 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 14 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of guarnatees by lochay investments limited in favour of clydesdale bank PLC dated 28 october 2002
    Brèves mentions
    8 fox covert avenue, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Lochay Investments Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 14 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of guarantees by kenmore investments limited in favour of clydesdale bank PLC dated 28 october 2002
    Brèves mentions
    8 fox covert avenue, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Kenmore Investments Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 14 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 8 foxcovert avenue, edinburgh..see microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 14 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2002
    Livré le 06 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 nov. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2002
    Livré le 05 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of guarantees by lochay investments limited in favour of clydesdale bank PLC
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lochay Investments Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 nov. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 mars 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2002
    Livré le 05 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of guarantees by kenmore investments limited in favour of clydesdale bank PLC
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kenmore Investments Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 nov. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 mars 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0