YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéYOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC245072
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wheatley House, 25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GHA (MANAGEMENT) LIMITED05 mars 200305 mars 2003

    Quels sont les derniers comptes de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    2 pagesAA

    Nomination de Mrs Josephine Armstrong en tant qu'administrateur le 02 juin 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2023 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sheila Margaret Gunn en tant que directeur le 29 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Mary Walford en tant que directeur le 29 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge SC2450720002 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2450720004 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2450720003 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Steven John Henderson en tant qu'administrateur le 30 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elaine Melrose en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2020 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Mccabe en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2019 sans mise à jour

    2 pagesCS01

    Inscription de la charge SC2450720002, créée le 30 oct. 2018

    21 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLISON, Anthony
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    Secrétaire
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Scotland
    224595300001
    ARMSTRONG, Josephine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Administrateur
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish121182240003
    HENDERSON, Steven John
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Administrateur
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish188575210001
    CRAIG, Kirsten Mary
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Scotland
    British188422900001
    HENDERSON, Julia Anne
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Secrétaire
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British151777670001
    LENNON, Michael Andrew
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    Secrétaire
    3 Ashton Road
    G12 8SP Glasgow
    British94455270001
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Secrétaire
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    British160706540001
    MOIR, Gordon Ivor
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Secrétaire
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    British150776680001
    STEVENSON, Donna Lesley
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    142 Hyndland Road
    G12 9PN Glasgow
    Lanarkshire
    British100054160002
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secrétaire
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    BLYTH, William Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish173115270001
    DEANS, Colin Stirling
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    Administrateur
    Flat 21 5 Birness Drive
    G43 1TA Glasgow
    ScotlandBritish103983110001
    DILLON, Margaret Jean
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    133 Caldarvan Street
    G22 5RG Glasgow
    Lanarkshire
    UkBritish67916130001
    DOUGAN, Elizabeth
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Administrateur
    2 Taylor Place
    Townhead
    G4 0PA Glasgow
    Great BritainBritish86590460001
    FURY, John Gerard
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    Administrateur
    25 Walnut Road
    G22 6EU Glasgow
    British95858230001
    FYFE, Maria
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    10 Ascot Avenue
    G12 0AX Glasgow
    Lanarkshire
    British90275680001
    GOLDIE, John
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish80585870001
    GUNN, Sheila Margaret
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Administrateur
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish52725500002
    HASTIE, John
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    House 96 40 Dumbreck Court
    G20 9HE Glasgow
    Lanarkshire
    British111668800001
    ISDALE, Graham
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritish163723820001
    LEONARD, Gerald Richard, Bailie
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    178 Briarcroft Road
    G33 1RH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish66744820001
    LOGAN, Mark Gerard
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Administrateur
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish47812710004
    LOGAN, Mark Gerard
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish47812710004
    MASON, Christopher Michael, Dr.
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    Administrateur
    25 Braidholm Road
    G46 6HS Giffnock
    East Renfrewshire
    United KingdomBritish105452470001
    MASTERTON, Williamina
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish100910850001
    MASTERTON, Williamina
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    50 Beil Drive
    Yoker
    G13 4DB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910850001
    MCCABE, Michael
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    ScotlandBritish154804360001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910990001
    MCEWING, Isabel
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    37 Estate Road
    G32 8BP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100910990001
    MCGUIRE, Alexander Serrels
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    Administrateur
    Trongate
    G1 5HF Glasgow
    177
    Scotland
    United KingdomBritish154804060001
    MCKINVEN, John
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    598 Boydstone Road
    Carnwadric
    G46 8NF Glasgow
    Lanarkshire
    British102007460001
    MCVICAR, John
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    58 Leighton Street
    High Ruchill
    G20 9HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Great BritainBritish120516560001
    MELROSE, Elaine
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    Administrateur
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House, 25
    Glasgow
    ScotlandBritish208961820001
    RYAN, George
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    Administrateur
    Hamilton Road
    Mount Vernon
    G32 9QQ Glasgow
    226
    UkBritish133071420001
    SHEDDEN, Alfred Charles
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    17 Beaumont Gate
    G12 9ED Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1213170002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    06 avr. 2016
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    25 Wheatley House
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany Ltd By Guarantee
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc426094
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    YOURPLACE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2018
    Livré le 06 nov. 2018
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transactions
    • 06 nov. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2018
    Livré le 06 nov. 2018
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transactions
    • 06 nov. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 oct. 2018
    Livré le 06 nov. 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties as Defined in the Instrument Accompanying This Form MR01
    Transactions
    • 06 nov. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 08 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in respect of the gha liabilities and all obligations under any of the relevant documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0