SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC245928 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 5 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Joseph Mark Linney le 24 juil. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher James Tanner le 24 juil. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2018 | 33 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Spurr le 19 mars 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Shanks Pfi Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 oct. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Nomination de Mr William Spurr en tant qu'administrateur le 23 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Alfred Cowan en tant que directeur le 22 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2017 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mars 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2016 | 31 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanna Griffiths en tant que directeur le 29 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alistair Daniel Brookes en tant que directeur le 27 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Alfred Cowan en tant qu'administrateur le 28 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Ian Cartwright en tant que directeur le 25 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Adam Nathaniel Richford en tant qu'administrateur le 25 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alistair Daniel Brookes en tant qu'administrateur le 01 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard | Secrétaire | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | British | 130189950001 | ||||||
| LINNEY, Joseph Mark | Administrateur | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London England | Scotland | British | 63161960001 | |||||
| RICHFORD, Adam Nathaniel | Administrateur | c/o Mr Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 126705600001 | |||||
| SPURR, William | Administrateur | c/o Mr Philip Griffin-Smith Renewi Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 126011000001 | |||||
| TANNER, Christopher James | Administrateur | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Foresight Group Llp The Shard London | England | British | 134603140001 | |||||
| GIBSON, Carolyn Ann | Secrétaire | Polo Barn Nairdwood Lane HP16 0QH Great Missenden Buckinghamshire | British | 119043460001 | ||||||
| KAYE, Paul | Secrétaire | Old Market Place Market Lane Greet GL54 5BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 3245340002 | ||||||
| BURNESS | Secrétaire désigné | 242 West George Street G2 4QY Glasgow | 900020360001 | |||||||
| BURNESS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| AITCHISON, Nigel Ian | Administrateur | Willow House 29 High Street Silverstone NN12 8US Towcester Northamptonshire | England | British | 88285320001 | |||||
| AVERILL, Michael Charles Edward | Administrateur | Little Meadow Upton Road Dinton HP17 8UQ Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 24913560002 | |||||
| BROOKES, Alistair Daniel | Administrateur | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 196460830001 | |||||
| CARTWRIGHT, Robert Ian | Administrateur | c/o Phil Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 73331440001 | |||||
| CLARKE, Michael James | Administrateur | Derwen House Kibblestone Road ST15 8UJ Stone Staffordshire | England | British | 154591790014 | |||||
| COWAN, Mark Alfred | Administrateur | c/o C/O Mr Philip Griffin-Smith Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | Scotland | British | 211107930001 | |||||
| DOWNES, David John | Administrateur | Holden Brook New Barn Lane RH5 5PF Ockley Surrey | United Kingdom | British | 37289200002 | |||||
| EGLINTON, Peter Damian | Administrateur | c/o Philip Griffin-Smith, Shanks Group Plc Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | United Kingdom | British | 137660810001 | |||||
| GOODFELLOW, Ian Frederick | Administrateur | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 28725450004 | |||||
| GRIFFITHS, Joanna | Administrateur | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 176450190001 | |||||
| HARDY, David Michael | Administrateur | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | England | British | 106339430006 | |||||
| HARMER, Andrew Keith | Administrateur | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 129905330002 | |||||
| MCVICKER, Alan William Fullerton | Administrateur | Ballykeel East Tulchan Steadings PH1 3SG Glenalmond Perthshire | British | 142373580001 | ||||||
| MULLIGAN, David Kevin | Administrateur | c/o Mr Philip Griffin-Smith Shanks Group Plc Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire England | England | British | 74215210003 | |||||
| PEARSON, Andrew Stephen | Administrateur | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | United Kingdom | British | 91780000001 | |||||
| RAY, Stephen Leslie | Administrateur | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 169241640001 | |||||
| SAUNDERS, Mark Ian | Administrateur | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire | England | British | 139588670003 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Administrateur | Auckland Park Mount Farm MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162166120001 | |||||
| STOCKLEY, Darren | Administrateur | 52 Paddock Gardens SO41 9ES Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 61712020003 | |||||
| SURCH, Christopher | Administrateur | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138144350001 | |||||
| TRANTER, Julian Ashley | Administrateur | Auckland Park, Mount Farm Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House United Kingdom | United Kingdom | British | 148676690001 | |||||
| WAPLES, Christopher Brian | Administrateur | 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 41387640003 | |||||
| WELHAM, Fraser Andrew Norton | Administrateur | Pennard Terry Road HP13 6QJ High Wycombe Buckinghamshire | Uk | British | 105268510002 | |||||
| BURNESS (DIRECTORS) LIMITED | Administrateur désigné | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900019120001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Laing Environmental Assets Group (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Renewi Pfi Investments Limited | 06 avr. 2016 | Auckland Park Bletchley MK1 1BU Milton Keynes Dunedin House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SHANKS DUMFRIES AND GALLOWAY HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Créé le 25 nov. 2004 Livré le 16 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The right,title and interest in and to the assigned agreements, the security guarantees and all of the proceeds thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 25 nov. 2004 Livré le 09 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0