ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED

ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARMADILLO SELF STORAGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC246789
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor 1 Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Adrian Charles Jonathan Lee en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr James Ernest Gibson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr John Trotman en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Shauna Beavis en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2014 au 31 mars 2015

    3 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Iain Bond en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Thorp en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Taylor Wessing Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2013

    État du capital au 02 avr. 2013

    • Capital: GBP 100,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Nomination de Timothy Geoffrey Thorp en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Iain Douglas Bond le 11 avr. 2011

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Sharon Kerridge en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sharon Diana Mandy Cook le 02 févr. 2011

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEAVIS, Shauna
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Dens
    Surrey
    Uk
    Secrétaire
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Dens
    Surrey
    Uk
    British187348730001
    GIBSON, James Ernest
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    Administrateur
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    EnglandBritish81633220002
    LEE, Adrian Charles Jonathan
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    Administrateur
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    EnglandBritish135454630001
    TROTMAN, John Richard
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    Administrateur
    Bridge Road
    GU19 5AT Bagshot
    2 The Deans
    Surrey
    Uk
    EnglandBritish186475520001
    HENNESSY, Linda
    22 Balmoral Gardens
    EH54 9EX Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    22 Balmoral Gardens
    EH54 9EX Livingston
    West Lothian
    British64867690001
    GILLESPIE MACANDREW WS
    31 Melville Street
    EH3 7JQ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    31 Melville Street
    EH3 7JQ Edinburgh
    Midlothian
    661890001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Secrétaire
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    84071220002
    BOND, Iain Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish68687180001
    DE ALBUQUERQUE, Simon Peter
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    Administrateur
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    EnglandBritish150525130001
    HODGSON, Paul Macgregor
    Breckenbrough Farm
    Brough Park
    DL10 7PL Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    Breckenbrough Farm
    Brough Park
    DL10 7PL Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish79279270002
    HODGSON, Simon Squair
    15 Grosvenor Crescent
    EH12 5EL Edinburgh
    Administrateur
    15 Grosvenor Crescent
    EH12 5EL Edinburgh
    ScotlandBritish89025200002
    JACK, Alister William
    Courance
    DG11 1TP Lockerbie
    Dumfrieshire
    Administrateur
    Courance
    DG11 1TP Lockerbie
    Dumfrieshire
    ScotlandBritish159211330001
    JACK, James Pringle
    16 Glencairn Crescent
    EH12 5BT Edinburgh
    Administrateur
    16 Glencairn Crescent
    EH12 5BT Edinburgh
    British91549320002
    KERRIDGE, Sharon Diana Mandy
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish128267610003
    MACKEY, Paul Emmanuel
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomIrish11264820014
    STENHOUSE, Richard Guy Thomas
    Mansefield
    Manse Street
    PA13 4NH Kilmacolm
    Renfrewshire
    Administrateur
    Mansefield
    Manse Street
    PA13 4NH Kilmacolm
    Renfrewshire
    ScotlandBritish801920003
    THORP, Timothy Geoffrey
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish66923730003

    ARMADILLO SELF STORAGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 16 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at loons road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 2005
    Livré le 21 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold property at goodlass road, speke, merseyside MS330686.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 oct. 2005
    Livré le 20 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage over all that freehold property known as part of victoria works on the north east side of victoria road, fenton SF214970 including fixed and floating charges.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 1, plot e foresters park, sifin lane, deerby DY172556.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on east side of saville road, peterborough & land lying to north of atherstone avenue, peterborough CB245824 CB275664 CB275886.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings on north side of teesway, north tees industrial estate, stockton on tees CE159736 CE159754.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold and leasehold land and property at site of the commodore cinema & portia street, kirkdale, bootle, liverpool MS387342 MS382822.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 29 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The freehold land on the south side of parkway avenue, sheffield, south yorkshire.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 2005
    Livré le 01 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings at spyvee street, kingston upon hull HS41013.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 2004
    Livré le 28 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mai 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 24 avr. 2003
    Livré le 29 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Noble Grossart Limited
    Transactions
    • 29 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0