RUBY DCO SIX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBY DCO SIX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC247115
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBY DCO SIX LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLARK MUNRO LIMITED07 juil. 200307 juil. 2003
    BLP 2003-29 LIMITED02 avr. 200302 avr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des détails de Big Pharma Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland à Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP le 18 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed clark munro LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 25 août 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 août 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 16 août 2023

    • Capital: GBP 0.01
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    33 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Ratification of directors 07/09/2022
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPRANK, Thorsten
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    Administrateur
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    EnglandGerman203900280002
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    British101256650001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    LINTS, Simon Philip
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    British56429650002
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005150001
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    British101256650001
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman172030260001
    CLARK, Colin Edward
    Abbeyfield House
    Old Town
    AB55 5DQ Keith
    Banffshire
    Administrateur
    Abbeyfield House
    Old Town
    AB55 5DQ Keith
    Banffshire
    United KingdomBritish85269300002
    COCHRANE, John
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    ScotlandBritish153437260001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGerman238936580003
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Administrateur
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritish54544790004
    LINTS, Simon Philip
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4a Mosspark Road
    Milngavie
    G62 8NJ Glasgow
    Lanarkshire
    British56429650002
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman220582440001
    MCGROARY, Dianne
    31 Dumgoyne Drive
    Bearsden
    G61 3AW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    31 Dumgoyne Drive
    Bearsden
    G61 3AW Glasgow
    Lanarkshire
    British66186900001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WINCHESTER, Randolph Dale
    Ash Cottage
    Banff Road
    AB55 5HA Keith
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Ash Cottage
    Banff Road
    AB55 5HA Keith
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish80145840001
    WISEMAN, Graham
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish299860960001
    BLP CREATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005130001
    BLP FORMATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO SIX LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 avr. 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc294226
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RUBY DCO SIX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 23 mars 2006
    Livré le 03 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 03 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises, 30 seafield street, cullen BNF2121 & 29 seafield street, cullen BNF2020.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 2004
    Livré le 15 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    28-30 seafield street, cullen--title number BNF2121 & 29 seafield street, cullen--title number BNF2020.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 15 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 sept. 2003
    Livré le 17 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    69 high street & 1 chapel road, grantown-on-spey.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2003
    Livré le 16 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 16 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0