RUBY DCO SIX LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RUBY DCO SIX LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC247115 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RUBY DCO SIX LIMITED ?
| Adresse du siège social | Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street G2 1BP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO SIX LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO SIX LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Big Pharma Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland à Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP le 18 sept. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed clark munro LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 août 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 août 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital au 16 août 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Statuts | 33 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RUBY DCO SIX LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Administrateur | International House, Crays Avenue BR5 3RS Orpington Office 5 United Kingdom | England | German | 203900280002 | |||||
| BAXTER, Anthony | Secrétaire | Highview 21 Chater Drive CW5 7GH Nantwich Cheshire | British | 101256650001 | ||||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secrétaire | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Secrétaire | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | 163214890001 | |||||||
| LINTS, Simon Philip | Secrétaire | 4a Mosspark Road Milngavie G62 8NJ Glasgow Lanarkshire | British | 56429650002 | ||||||
| BLP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005150001 | |||||||
| BAXTER, Anthony | Administrateur | Highview 21 Chater Drive CW5 7GH Nantwich Cheshire | British | 101256650001 | ||||||
| BEER, Thorsten | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| CLARK, Colin Edward | Administrateur | Abbeyfield House Old Town AB55 5DQ Keith Banffshire | United Kingdom | British | 85269300002 | |||||
| COCHRANE, John | Administrateur | 23 Maxwell Drive G74 4HH East Kilbride Lanarkshire | Scotland | British | 153437260001 | |||||
| HALL, Wendy Margaret | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Germany | German | 238936580003 | |||||
| KEEN, Christian | Administrateur | Hampden Park Industrial Estate G42 0PH Glasgow 204 Polmadie Road Scotland | England | British | 54544790004 | |||||
| LINTS, Simon Philip | Administrateur | 4a Mosspark Road Milngavie G62 8NJ Glasgow Lanarkshire | British | 56429650002 | ||||||
| LIPP, Hanns Martin | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| MCGROARY, Dianne | Administrateur | 31 Dumgoyne Drive Bearsden G61 3AW Glasgow Lanarkshire | British | 66186900001 | ||||||
| SHEPHERD, William | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| WINCHESTER, Randolph Dale | Administrateur | Ash Cottage Banff Road AB55 5HA Keith Aberdeenshire | Scotland | British | 80145840001 | |||||
| WISEMAN, Graham | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 299860960001 | |||||
| BLP CREATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005130001 | |||||||
| BLP FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005140001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO SIX LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Dco Five Limited | 06 avr. 2016 | West George Street G2 1BP Glasgow Clyde Offices, 2nd Floor, 48 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RUBY DCO SIX LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 23 mars 2006 Livré le 03 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 16 nov. 2004 Livré le 23 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Shop premises, 30 seafield street, cullen BNF2121 & 29 seafield street, cullen BNF2020. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 10 nov. 2004 Livré le 15 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 28-30 seafield street, cullen--title number BNF2121 & 29 seafield street, cullen--title number BNF2020. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 12 sept. 2003 Livré le 17 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 69 high street & 1 chapel road, grantown-on-spey. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 02 sept. 2003 Livré le 16 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0