MACDONALD HOTELS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MACDONALD HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC247423 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Crutherland House And Spa Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 24 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 24 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 26 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes consolidés établis au 26 sept. 2024 | 42 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 03 juin 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Période comptable précédente raccourcie du 25 sept. 2024 au 24 sept. 2024 | 1 pages | AA01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Hugh Gillies le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Iain Gillies le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Donald John Macdonald le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Mr James Dickie Davidson en tant qu'administrateur le 14 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Miss Marjorie Macdonald en tant qu'administrateur le 14 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Stuart Paul Davies en tant qu'administrateur le 14 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modifications à la charge flottante SC2474230021 | 103 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC2474230019 | 103 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC2474230032 | 104 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC2474230035 | 104 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC2474230030 | 103 pages | 466(Scot) | ||
Inscription de la charge SC2474230034, créée le 21 févr. 2025 | 55 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC2474230035, créée le 21 févr. 2025 | 13 pages | MR01 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ | 1 pages | AD04 | ||
Comptes de groupe modifiés jusqu'au 28 sept. 2023 | 41 pages | AAMD | ||
Comptes consolidés établis au 28 sept. 2023 | 42 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge SC2474230018 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge SC2474230024 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC2474230026 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACFARLANE, Stephanie Rose | Secrétaire | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | 318337980001 | |||||||
| DAVIDSON, James Dickie | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 83786790001 | |||||
| DAVIES, Stuart Paul | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Wales | British | 189892480002 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 289448940001 | |||||
| GILLIES, Hugh | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 301475200001 | |||||
| GILLIES, Iain | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 436470002 | |||||
| MACDONALD, Donald John | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 557590001 | |||||
| MACDONALD, Marjorie | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 186033760001 | |||||
| SMITH, Gerard Henry | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 169821320001 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Secrétaire | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 218645150001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Secrétaire | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 191035270001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Secrétaire | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 150227120001 | |||||||
| FRASER, Robert Gordon | Secrétaire | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | British | 120322350002 | ||||||
| GILMURRAY, Kieran | Secrétaire | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | 199214750002 | |||||||
| HEENEY, Caroline | Secrétaire | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | 309071060001 | |||||||
| MCCREATH, Matthew Brook | Secrétaire | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | British | 165547750001 | ||||||
| ROSS, Mark | Secrétaire | 58 Kettilstoun Mains EH49 6SL Linlithgow West Lothian | British | 106803450001 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Administrateur | Level 1 Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Uberior Ventures Limited | Scotland | British | 73849040001 | |||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Administrateur | 68 Ravelston Dykes EH12 6HF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 34800860003 | |||||
| BURNETT, Neil Scott | Administrateur | 5 Cluny Avenue EH10 4RN Edinburgh | British | 93937250001 | ||||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Administrateur | Gospatric House Bankhead Road Dalmeny EH30 9TT Edinburgh | Scotland | British | 104262520001 | |||||
| COOK, Robert Barclay | Administrateur | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | England | British | 172635260001 | |||||
| CUMMING, Andrew John | Administrateur | Suffolk Lane EC4R 0AX London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Administrateur | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Administrateur | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||
| FALLS, Aaron Peter | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 279163090001 | |||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Administrateur | Level 1 Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Uberior Ventures Limited | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||
| GRANT, Mary Alexander | Administrateur | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | United Kingdom | British | 69815990010 | |||||
| GUILE, David Andrew | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | United Kingdom | British | 100133280001 | |||||
| JACKSON, Simon Richard | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 194029260001 | |||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Administrateur | 18 Hermitage Drive EH10 6BZ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||
| MACDONALD, Ruaridh | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 138199130001 | |||||
| MCBURNIE, Jason | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 202600000001 | |||||
| MCGILL, Michael Scott | Administrateur | 5 Lygon Road EH16 5QD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 99070570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACDONALD HOTELS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Monument/Macdonald Partnership | 06 avr. 2016 | Dykedale FK15 0DH Dunblane Cardrona Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Cardrona Charitable Trust | 06 avr. 2016 | Dykedale FK15 0DH Dunblane Cardrona Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0