FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED

FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC247751
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o DELOITTE LLP
    Lomond Hosue,
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    B L DEVELOPMENTS (SHRUBHILL) LIMITED23 déc. 200423 déc. 2004
    BENSON LEVADE LIMITED16 avr. 200316 avr. 2003
    PACIFIC SHELF 1219 LIMITED14 avr. 200314 avr. 2003

    Quels sont les derniers comptes de FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    18 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    18 pages2.20B(Scot)

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:form 2.32B(scot) notice of insufficient property for distribution to unsecured creditors other than by virtue of S176A(2)a
    1 pagesLIQ MISC

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Cessation de la nomination de Paul Mcphie Johnston en tant que directeur le 31 déc. 2012

    1 pagesTM01

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    38 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)

    16 pages2.15B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de The Aurora Building C/O Hamilton Capital Partners 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS le 14 sept. 2012

    4 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    4 pages2.11B(Scot)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juil. 2012

    État du capital au 03 juil. 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 20 avr. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Seng Khoon Ng en tant que secrétaire le 20 avr. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stanley Swee Han Quek en tant que directeur le 20 avr. 2011

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Sterling House 20 Renfield Street Glasgow G2 5AP le 03 avr. 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Seng Ng en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Valsec Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Stanley Quek en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAPPING, Andrew Christopher
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Hindley House
    Northumberland
    Administrateur
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Hindley House
    Northumberland
    United KingdomBritish113467730001
    MYERSCOUGH, Philip John
    4b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    Secrétaire
    4b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    British77976160001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Secrétaire
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    ROBERTSON, Sandra Alison
    6 East Lorimer Place
    Cockenzie
    EH32 0JD Prestonpans
    East Lothian
    Secrétaire
    6 East Lorimer Place
    Cockenzie
    EH32 0JD Prestonpans
    East Lothian
    British117144610001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7307485
    154154420001
    JOHNSTON, Paul Mcphie
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Exchange Place 3
    Administrateur
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Exchange Place 3
    ScotlandBritish87082600003
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Administrateur
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    MCAREAVEY, John Owen
    Drylaw House
    32 Groat Hill Road North
    EH4 2SL Edinburgh
    Administrateur
    Drylaw House
    32 Groat Hill Road North
    EH4 2SL Edinburgh
    ScotlandBritish79185720001
    MCAREAVEY, John Owen
    Drylaw House
    32 Groat Hill Road North
    EH4 2SL Edinburgh
    Administrateur
    Drylaw House
    32 Groat Hill Road North
    EH4 2SL Edinburgh
    ScotlandBritish79185720001
    MITCHELL, Michael Wilson Jamieson
    52 Laing Gardens
    EH52 6XT Broxburn
    West Lothian
    Administrateur
    52 Laing Gardens
    EH52 6XT Broxburn
    West Lothian
    British88805570001
    MYERSCOUGH, Philip John
    4b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    Administrateur
    4b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    British77976160001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Administrateur
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    THOMAS, Alastair
    Old Orchard Cottage
    Church Lane
    OX5 2UA Charlton On Otmoor
    Oxfordshire
    Administrateur
    Old Orchard Cottage
    Church Lane
    OX5 2UA Charlton On Otmoor
    Oxfordshire
    EnglandBritish155371690001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 04 oct. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shrubhill garage, leith walk, edinburgh MID74209.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 06 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hamilton Portfolio Partnership
    Transactions
    • 06 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 oct. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 05 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fairbriar PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 04 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 oct. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 06 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Former shrubhill depot, shrub place, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 mars 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    FRASERS HAMILTON (SHRUBHILL) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 sept. 2012Administration started
    29 août 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    practitioner
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0