CS PROPERTIES SALES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCS PROPERTIES SALES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC249903
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CS PROPERTY SALES LIMITED21 mai 200321 mai 2003

    Quels sont les derniers comptes de CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    22 pagesLIQ14(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    15 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 160 Dundee Street Edinburgh EH11 1DQ* le 08 janv. 2014

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.31B(Scot)

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    2 pages2.30B(Scot)

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    15 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)

    16 pages2.15B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)

    33 pages2.15B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 1St Floor, 221 West George Street, Glasgow G2 2ND* le 22 mai 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Qui sont les dirigeants de CS PROPERTIES SALES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHOPRA, Ajay
    Rockfield
    Mugdock, Milngavie
    G62 8EJ Glasgow
    Secrétaire
    Rockfield
    Mugdock, Milngavie
    G62 8EJ Glasgow
    Scottish66174100003
    CHOPRA, Ajay
    Rockfield
    Mugdock, Milngavie
    G62 8EJ Glasgow
    Administrateur
    Rockfield
    Mugdock, Milngavie
    G62 8EJ Glasgow
    ScotlandScottish66174100003
    SONI, Ajay
    17 Crawford Street
    W1H 1PF London
    Administrateur
    17 Crawford Street
    W1H 1PF London
    EnglandBritish15861400003
    SONI, Kumar Rodney
    17 Crawford Street
    W1H 1PF London
    Administrateur
    17 Crawford Street
    W1H 1PF London
    United KingdomBritish78171440003
    FIRST SCOTTISH SECRETARIES LIMITED
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    Secrétaire désigné
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    900008570001
    FIRST SCOTTISH INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    Administrateur désigné
    St Davids House
    St Davids Drive
    KY11 9NB Dalgety Bay
    900008560001

    CS PROPERTIES SALES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 02 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the deposit.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 02 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    162 gloucester place london LN90161.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 308 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 3
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 02 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    17 crawford street london LN107664.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 508 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 5
    Legal charge
    Créé le 05 déc. 2007
    Livré le 13 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    22 wilton place, london NG785898.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 708 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 7
    Legal charge
    Créé le 16 mars 2007
    Livré le 23 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as 17 crawford street, london LN107664.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 408 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 4
    Legal charge
    Créé le 07 mars 2007
    Livré le 23 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as 162 gloucester place, london LN90161.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 208 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Standard security
    Créé le 05 janv. 2007
    Livré le 10 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects unit 1, festival court, 200 brand street, glasgow (title number gla 160368); the subjects unit 2, festival court, 190 brand street, glasgow (title number gla 168564) and the subjects on the north side of brand street, glasgow (title number gla 153571).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 20 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    119 crawford street london LN161238.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 608 juin 2013Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 6
    Floating charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 19 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 19 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 25 oct. 2004
    Livré le 29 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 3, festival court, brand street, govan, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 29 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 2, 190 festival court, brand street, govan, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 oct. 2004
    Livré le 20 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 1, 200 festival court, brand street, govan, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 20 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 août 2004
    Livré le 26 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 26 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 119 crawford street, london LN161238.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Falt 12, bryanston mansions, york street, london NGL723947.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat 4, 9 upper montagu street, london NGL824022.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 02 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charge over flat 4, 9 upper montagu street, london NGL824022; flat 12 bryanston mansions, york street, london NGL723747 & ascot house, 119 crawford street, london LN161238.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CS PROPERTIES SALES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 mai 2012Administration started
    29 juin 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kenneth Robert Craig
    48 St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    practitioner
    48 St Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Thomas Campbell Maclennan
    Tenon Recovery
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    practitioner
    Tenon Recovery
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Alexander Iain Fraser
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    practitioner
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    2Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    3Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    4Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    5Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    6Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    7Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Rolleston Gilbert Perkin
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Thomas William Stephen Webb
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    administrative receiver
    Henrietta House Henrietta Place
    W1G 0NB London
    Notesscottish-insolvency-info
    8
    DateType
    29 juin 2015Commencement of winding up
    15 mars 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alexander Iain Fraser
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    proposed liquidator
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Thomas Campbell Maclennan
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    proposed liquidator
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0