COLERIDGE (NO. 28) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOLERIDGE (NO. 28) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC256999
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COLERIDGE (NO. 28) LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe COLERIDGE (NO. 28) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1st Floor Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COLERIDGE (NO. 28) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COLERIDGE (NO. 28) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    44 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de Neil Kenneth Robertson en tant que directeur le 24 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 mars 2016

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 05 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Kenneth Robertson en tant qu'administrateur le 05 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2015

    État du capital au 14 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Fraser James Kennedy en tant que directeur le 14 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Claire Treacy en tant qu'administrateur le 14 août 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2014

    État du capital au 14 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    3 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2013

    État du capital au 15 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Valsec Director Limited le 01 juil. 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fraser James Kennedy le 01 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Fraser James Kennedy le 05 nov. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    25 pagesMG01s

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COLERIDGE (NO. 28) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05307786
    102622300002
    FOWLIE, Frank Alexander
    14/4 Hermand Crescent
    EH11 1LP Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    14/4 Hermand Crescent
    EH11 1LP Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British89314050001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park
    YO32 3LN Haxby
    Yorkshire
    Secrétaire
    2 Newdale
    Usher Park
    YO32 3LN Haxby
    Yorkshire
    British82753760001
    BROWN, Stewart David
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    Administrateur désigné
    6 Moat Place
    EH14 1NY Edinburgh
    British900023690001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    FOWLIE, Frank Alexander
    14/4 Hermand Crescent
    EH11 1LP Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    14/4 Hermand Crescent
    EH11 1LP Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British89314050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Administrateur
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (NO. 28) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 02 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession deed to guarantee and debenture
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 07 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Accession agreement and charge
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 04 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 29 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as walmsley house, 214-222 st john street and 15-19 agdon street, finsbury, london--title number NGL770606; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 oct. 2003
    Livré le 05 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    COLERIDGE (NO. 28) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mars 2016Commencement of winding up
    24 juil. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0