THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC257330 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 37 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Amey Precision House Mcneil Drive Motherwell ML1 4UR Scotland à 272 Bath Street Glasgow G2 4JR le 10 juil. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Christopher Thomas Solley en tant qu'administrateur le 31 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Martin Timothy Smith en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Oytun Altasli Widmer en tant qu'administrateur le 26 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr John Gerard Connelly en tant qu'administrateur le 26 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Oytun Altasli Widmer en tant que directeur le 26 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr David Epps en tant qu'administrateur le 22 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Alexandra Jane Hardwicke en tant que directeur le 22 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 36 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Neil Andrew Woodburn en tant qu'administrateur le 09 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Alasdair Campbell en tant que directeur le 09 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Neeti Mukundrai Anand en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Alexandra Jane Hardwicke en tant qu'administrateur le 27 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 36 pages | AA | ||
Nomination de Ms Neeti Mukundrai Anand en tant qu'administrateur le 27 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Oytun Altasli Widmer en tant qu'administrateur le 27 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nadiia Kaznacheieva en tant que directeur le 06 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Neeti Mukundrai Anand en tant que directeur le 06 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul James Hatcher en tant que secrétaire le 24 mai 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Albany Secretariat Limited en tant que secrétaire le 24 mai 2023 | 2 pages | AP04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mars 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Qui sont les dirigeants de THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England |
| 303585870001 | ||||||||||
| ALTASLI WIDMER, Oytun | Administrateur | c/o Dif Uk Threadneedle Street EC2R 8HP London 62 England | United Kingdom | British | 311755640001 | |||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Administrateur | c/o Dif Uk Threadneedle Street EC2R 8HP London 62 England | England | British | 323811250001 | |||||||||
| EPPS, David | Administrateur | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | England | British | 329746580001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Administrateur | St Andrew Square EH2 2AH Edinburgh 6 Scotland Scotland | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| PEARMAN, Katherine Anne Louise | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 226963920001 | |||||||||
| POUPARD, Natalia | Administrateur | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | England | British | 254916130001 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Administrateur | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Administrateur | c/o Albany Spc Services Limited 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England | England | British | 137607780003 | |||||||||
| HATCHER, Paul James | Secrétaire | 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England England | 294214050001 | |||||||||||
| MACROBERTS - (FIRM) | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | 900018030001 | |||||||||||
| MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | 60 York Street G2 8JX Glasgow Capella Building (Tenth Floor) Scotland |
| 130204580001 | ||||||||||
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| ALTASLI WIDMER, Oytun | Administrateur | 62 Threadneedle Street EC2R 8HP London Dif Uk England | United Kingdom | British | 311755640001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Administrateur | 62 Threadneedle Street EC2R 8HP London Dif Uk England | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Administrateur | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Administrateur | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 250186840001 | |||||||||
| ANDERSON, Derek Orr | Administrateur | 9 The Spinneys KY11 9SL Dalgety Bay Fife | Scotland | British | 161345590001 | |||||||||
| BRADBURY, Richard George | Administrateur | Beech Cottage Beech Lane WA6 6LP Norley Cheshire | British | 42234330002 | ||||||||||
| BREE, Rhona Macdonald | Administrateur | Flat 3/2 64 Miller Street G1 1DT Glasgow Lanarkshire | British | 99563640001 | ||||||||||
| CAMPBELL, Alasdair | Administrateur | Bartholemew Close EC1A 7HH London 1 England England | Scotland | British | 215915630001 | |||||||||
| CHESTER, Jonathan Roger | Administrateur | 2 Giffard Close ST19 9HD Brewood Stafford | British | 94576750001 | ||||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Administrateur | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | Scotland | British | 152971000001 | |||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | Scotland | British | 152971000001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Administrateur | c/o C/O Hsbc Specialist Fund Management Limited Canada Square E14 5HQ London 8 | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| COPPIN, Andrew John | Administrateur | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building United Kingdom | United Kingdom | British | 130949770001 | |||||||||
| COTTRELL, Keith | Administrateur | 12 Brightlingsea Place E14 8DB London | British | 88691090001 | ||||||||||
| FALERO, Louis Javier | Administrateur | Level 4 2 - 4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 301858300001 | |||||||||
| FALERO, Louis Javier | Administrateur | c/o C/O Dif Idol Lane EC3R 5DD London 2-4 England | England | British | 301858300001 | |||||||||
| FARLEY, Graham | Administrateur | 9 Manor Close Hinstock TF9 2TZ Market Drayton Salop | United Kingdom | British | 183764380001 | |||||||||
| FORSYTH, Peter, Dr | Administrateur | Long Kensome, South Green Kirtlington OX5 3HJ Oxford Oxfordshire | England | British | 207405700001 | |||||||||
| GHAFOOR, Asif | Administrateur | Floor Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 277343840001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Administrateur | St. Mary Axe EC3A 8BF London 30 St Mary Axe England | United Kingdom | British | 206362380001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE RENFREWSHIRE SCHOOLS PARTNERSHIP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsdl Nominees Limited | 06 avr. 2016 | Trinity Road HX1 2RG Halifax Trinity Road England | Oui | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Rsp (Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | Precision House Mcneil Drive ML1 4UR Holytown Amey Motherwell Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
| Bank Of Scotland Plc | 06 avr. 2016 | The Mound EH1 1YZ Edinburgh Bank Of Scotland Scotland | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0