RESTAURANTDIARY.COM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRESTAURANTDIARY.COM LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC258100
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 3 180 West George Street
    G2 2NR Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLEARCLICK RESTAURANTS LIMITED13 nov. 200313 nov. 2003
    BLP 2003-56 LIMITED23 oct. 200323 oct. 2003

    Quels sont les derniers comptes de RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2027
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 oct. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 oct. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de micro-entité établis au 30 juin 2025

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2024

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2024 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 36 Renfield Street Glasgow G2 1LU Scotland à Level 3 180 West George Street Glasgow G2 2NR le 24 oct. 2024

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2023 au 30 juin 2024

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Access Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 juil. 2023

    2 pagesPSC02

    Statuts

    12 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de Reef Global Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 juil. 2023

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Colin David Winning en tant que directeur le 03 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Adam John Witherow Brown en tant qu'administrateur le 03 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alexis Park en tant que directeur le 03 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Hugh Binns en tant qu'administrateur le 03 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael James Audis en tant qu'administrateur le 03 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Chris Andrew Armstrong Bayne en tant qu'administrateur le 03 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Statuts

    35 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Notification de Reef Global Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juin 2022

    2 pagesPSC02

    Cessation de Gourmet Experience Pte Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juin 2022

    1 pagesPSC07

    Cessation de Gourmet Experience Pte Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 juin 2022

    1 pagesPSC07

    Qui sont les dirigeants de RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AUDIS, Michael James
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    Administrateur
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    EnglandBritish248206260001
    BAYNE, Chris Andrew Armstrong
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    Administrateur
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    EnglandBritish310998740001
    BINNS, Robert Hugh
    Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    England
    Administrateur
    Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    England
    EnglandBritish206402020006
    BROWN, Adam John Witherow
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    United Kingdom
    Administrateur
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    United Kingdom
    EnglandBritish277451830001
    BECKWITH, Neil Scott
    Ailsa View 2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    Secrétaire
    Ailsa View 2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    British43484310002
    MORRISON, Robert Soutar
    21 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    Secrétaire
    21 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    British896800001
    WHITELAW, Linda Julie
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    Secrétaire
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    British64357620007
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005150001
    BECKWITH, Neil Scott
    Ailsa View 2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    Ailsa View 2 Academy Street
    KA10 6AQ Troon
    Ayrshire
    British43484310002
    CENT, Marcus Jack
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    United Arab EmiratesBritish156147740001
    CENT, Marcus Jack
    12/3 Castlebank Drive
    G11 6AD Glasgow
    Administrateur
    12/3 Castlebank Drive
    G11 6AD Glasgow
    ScotlandBritish103463780002
    CONYERS, Michael John
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    ScotlandBritish91719970004
    CONYERS, Nicola Jude
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    ScotlandBritish156146050002
    DALEY, Louise Maree
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    SingaporeAustralian245115010001
    DALEY, Louise Maree
    Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    16
    Scotland
    Administrateur
    Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    16
    Scotland
    SingaporeAustralian205195720001
    FARZIN, Arezoo
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    ScotlandBritish196770700001
    GROB, Pierre-Charles
    c/o D-Edge
    Rue Des Archives
    75003 Paris
    66
    France
    Administrateur
    c/o D-Edge
    Rue Des Archives
    75003 Paris
    66
    France
    FranceFrench277700570001
    HARINSTEIN, Jason
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    Administrateur
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    UsaAmerican177890280001
    HOYT, Mark Stephen
    West Chicago Avenue
    Suite 620
    IL 60657 Chicago
    600
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    West Chicago Avenue
    Suite 620
    IL 60657 Chicago
    600
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican165497520003
    ISSENBERG, Michael
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    SingaporeAustralian218760010001
    JOHNS, Christopher Benedict
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    United KingdomBritish48804970005
    KATZ, David Michael
    Sherman Avenue
    CA 94306 Palo Alto
    409
    California
    Usa
    Administrateur
    Sherman Avenue
    CA 94306 Palo Alto
    409
    California
    Usa
    UsaNorth American165497560001
    MORRISON, Robert Soutar
    C/O Mkm Commercial Holdings
    Dubai
    PO BOX 6850
    Uae
    Administrateur
    C/O Mkm Commercial Holdings
    Dubai
    PO BOX 6850
    Uae
    United Arab EmiratesBritish896800003
    PARK, Alexis
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    ScotlandBritish245069400001
    RUDIN, Gregory
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    Scotland
    Administrateur
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    Scotland
    UsaUnited States157622440001
    STEVENS, Paul Kendall
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    SingaporeAustralian245115070001
    WALKER, Donald Alastair Thomas
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    EnglandBritish156145810002
    WHITELAW, Colin James
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    Administrateur
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    ScotlandBritish35696260004
    WHITELAW, Linda Julie
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    Administrateur
    40 Sherbrooke Avenue
    G41 4EP Glasgow
    ScotlandBritish64357620007
    WILKINSON, Sarah Pamela Du Cane
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    United KingdomBritish323557900001
    WINNING, Colin David
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Administrateur
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    ScotlandBritish196666470001
    YASIN, Farhan
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    Scotland
    Administrateur
    Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    75
    Scotland
    UsaBritish157622280001
    BLP CREATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005130001
    BLP FORMATIONS LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Strathclyde
    900005140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RESTAURANTDIARY.COM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    03 juil. 2023
    Oakwood Drive
    Loughborough University Science & Enterprise Park
    LE11 3QF Loughborough
    Armstrong Building
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02343760
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Carnaby Street
    3rd Floor
    W1F 9PS London
    46a
    United Kingdom
    21 juin 2022
    Carnaby Street
    3rd Floor
    W1F 9PS London
    46a
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Acts
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement08573035
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Gourmet Experience Pte Limited
    1 Wallich Street
    Guoco Tower
    Singapore
    #17-01
    078881
    Singapore
    06 avr. 2018
    1 Wallich Street
    Guoco Tower
    Singapore
    #17-01
    078881
    Singapore
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementSingapore
    Autorité légaleSingapore Companies Act
    Lieu d'enregistrementAcra (Singapore)
    Numéro d'enregistrement201809361k
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Gourmet Experience Pte Ltd
    Wallich Street
    #17-01 Guoco Tower
    078881
    1
    Singapore
    06 avr. 2018
    Wallich Street
    #17-01 Guoco Tower
    078881
    1
    Singapore
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementSingapore
    Autorité légaleSingapore
    Lieu d'enregistrementAccounting And Corporate Regulatory Authority (Acra), Singapore
    Numéro d'enregistrement201809361k
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Michael John Conyers
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    06 avr. 2016
    Renfield Street
    G2 1LU Glasgow
    36
    Scotland
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0