IMPACT FUNDING PARTNERS LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IMPACT FUNDING PARTNERS LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC261186 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| Adresse du siège social | Robertson House 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 mars 2025 | 29 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Sara Diegoli en tant que directeur le 05 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Linda Paterson en tant que directeur le 07 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Cate Nelson-Shaw en tant que secrétaire le 28 avr. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 28 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Patricia Macfarlane en tant que secrétaire le 25 oct. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Sara Diegoli le 22 mai 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de James Nicol en tant que directeur le 22 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Jennifer Linda Paterson en tant qu'administrateur le 21 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Miss Laura Kathleen Steven en tant qu'administrateur le 21 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 29 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Patricia Imrie le 02 nov. 2023 | 1 pages | CH03 | ||
Nomination de Dr Sara Diegoli en tant qu'administrateur le 28 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr George Finnie en tant qu'administrateur le 30 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Gary Meek en tant que directeur le 30 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Nicol le 20 déc. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2022 | 30 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Alison Clare Gibb en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov. 2022 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de James Nicol en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Mr Grant Robertson Andrew en tant qu'administrateur le 23 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Gary Meek en tant qu'administrateur le 23 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON-SHAW, Cate | Secrétaire | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | 335195600001 | |||||||
| ANDREW, Grant Robertson | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 97480770001 | |||||
| FINNIE, George | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 240422640001 | |||||
| GIBB, Alison Clare | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 302863550001 | |||||
| HAZELHURST, Keeley Ann | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | United Kingdom | British | 210090220002 | |||||
| KOLLIATSAS, Christos | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | Greek,British | 302865160001 | |||||
| STEVEN, Laura Kathleen | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 205240050001 | |||||
| CARTER, Sandra Margaret | Secrétaire | Bartholomew House (Flat 3) 12 Duncan Street EH9 1SZ Edinburgh Midlothian | British | 71540270001 | ||||||
| GARDINER, Margaret Mckenzie | Secrétaire | 29 George Street FK15 9HE Dunblane Perthshire | British | 100356100001 | ||||||
| LOGAN, Eleanor Margaret, Dr | Secrétaire | 15 Queensferry Road EH4 3HB Edinburgh | British | 110456610003 | ||||||
| MACFARLANE, Patricia | Secrétaire | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | 274204200002 | |||||||
| WIMBLES, Keith Thomas | Secrétaire | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | British | 276644360001 | ||||||
| AHMAD, Pervin Akhtar Noor | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 197701250001 | |||||
| ALBA, Carlos Matthew | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 151812010001 | |||||
| ANWAR, Anela | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife | Scotland | British | 121090230001 | |||||
| BEDI, Iqbal Singh | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 219717360001 | |||||
| BIBI, Nasra | Administrateur | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 165773820001 | |||||
| BILIOURI-GRANT, Daphne | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 263275220001 | |||||
| BRUCE, Ailsa | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 265262180001 | |||||
| CALLAGHAN, Anne Duffy | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Scotland | British | 264169660001 | |||||
| CHAUDHRY, Farkhanada | Administrateur | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 91475090001 | |||||
| CORR, Bridgid | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Welsh | 165703570001 | |||||
| CRICHTON, Andrew George | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 259722630001 | |||||
| CUNNINGHAM, Michael | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 83188690002 | |||||
| DANIEL, Ronald | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 85386400001 | |||||
| DIEGOLI, Sara, Dr | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | United Kingdom | Italian | 314037940002 | |||||
| DOWNIE, Carol | Administrateur | The Lodge 227 Dalry Road EH11 2EQ Edinburgh Midlothian | Scotland | Scottish | 66178000001 | |||||
| EDWARDS, Gail Helen | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | United Kingdom | British | 165749060001 | |||||
| ELSLEY, Susan, Dr | Administrateur | 23 Marlborough Street EH15 2BD Edinburgh Lothian | Scotland | British | 87824760001 | |||||
| FIAMANYA, Eric Mensah | Administrateur | Unit 14, Dunfermline Business Centre, Izatt Avenue KY11 3BZ Dunfermline Fife | Scotland | British | 51341690001 | |||||
| GILES, Nina Mai Fung | Administrateur | 69 Niddrie Marischal Grove Craigmillar EH16 4LD Edinburgh | Scotland | British | 96864390001 | |||||
| GRIEVE, Shirley | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | British | 167279470001 | |||||
| GUEST, Douglas | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 165795430001 | |||||
| HANNAH, Angus John | Administrateur | Forth House Burnside Business Court North Road KY11 1NZ Inverkeithing Suite 3 Fife | Scotland | British | 185337650001 | |||||
| HAWTHORN, John Ogilvie | Administrateur | 2 Cedar Walk PA18 6BP Wemyss Bay | British | 94683070001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMPACT FUNDING PARTNERS LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Ms Alison Clare Gibb | 23 nov. 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr James Nicol | 30 juin 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Daphne Grant | 16 févr. 2022 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Oui |
Nationalité: British,Greek Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Joanna Mclaughlin | 09 nov. 2016 | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow Robertson House Scotland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0