PARTNERS FOR INCLUSION
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PARTNERS FOR INCLUSION |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | SC262549 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARTNERS FOR INCLUSION ?
| Adresse du siège social | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARTNERS FOR INCLUSION ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PARTNERS FOR INCLUSION ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 janv. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 10 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 janv. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PARTNERS FOR INCLUSION ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 pages | RP01AP01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Grethe Gullborg Schepers le 20 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Hanna Mayhew le 20 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Craig Edward Houps le 20 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Angela Kelly le 20 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Angela Marie Kelly le 19 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Grethe Schepers le 19 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Grethe Gullborg Schepers le 19 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Mary-Frances Felletti le 12 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Mary-Frances Felletti le 12 janv. 2026 | 1 pages | CH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Craig Houps le 12 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rod Leach le 09 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alex Goff le 08 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 37 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Caelan Grant en tant que directeur le 16 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Angela Marie Kelly en tant qu'administrateur le 28 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Alex Goff en tant qu'administrateur le 21 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Miss Hanna Mayhew en tant qu'administrateur le 21 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Caelan Grant en tant qu'administrateur le 21 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Lydia Cordell-Van Duuren en tant que directeur le 29 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rod Leach le 01 avr. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rod Leach le 18 févr. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Rod Leach en tant qu'administrateur le 03 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de PARTNERS FOR INCLUSION ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELLETTI, Mary Frances | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 315660770003 | |||||||
| FELLETTI, Mary Frances | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 256023460002 | |||||
| GOFF, Alexander Stephen | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | England | British | 338656900002 | |||||
| HOUPS, Craig Edward | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 316503710001 | |||||
| KELLY, Angela Marie | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | England | British | 308722130001 | |||||
| LEACH, Rodney Rawson | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 331307810002 | |||||
| MAYHEW, Hanna | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | England | British | 338644300001 | |||||
| RAE, Rona Elaine | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 288162170001 | |||||
| SCHEPERS, Grethe Gullborg | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | England | British | 312848510003 | |||||
| SKOVRON, Paul Howard | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 232258270001 | |||||
| DOSANJH, Chamkur | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 312968060001 | |||||||
| FELLETTI, Mary-Frances | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 309972710001 | |||||||
| KELLY, Doreen | Secrétaire | 56 Mauchline Road Hurlford KA1 5DF Kilmarnock | British | 62608990003 | ||||||
| MCDOWALL, Alison Munn | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 294254530001 | |||||||
| MCINTOSH, Scott Alexander | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 201928940001 | |||||||
| RICHMOND, Peter John | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 248867000001 | |||||||
| RICHMOND, Peter John | Secrétaire | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | 197364540001 | |||||||
| BARBOUR, Jill Ann | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 189091170001 | |||||
| BLACK, Patricia Ann | Administrateur | 32 Balgreen Avenue EH12 5SU Edinburgh | Scotland | British | 62609000004 | |||||
| CORDELL-VAN DUUREN, Lydia | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 312782010001 | |||||
| CURRIE, Caron | Administrateur | c/o Partners For Inclusion Limited Portland Street KA3 1AA Kilmarnock West Kirk 84 Ayrshire Scotland | Scotland | British | 185149300001 | |||||
| DOSANJH, Chamkur Singh | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 244063710005 | |||||
| EDGAR, Colin Best | Administrateur | Gartmore Road PA1 3NQ Paisley 62 Scotland | Scotland | British | 180889090002 | |||||
| FENTIE, Astra Jane | Administrateur | 157 Logan Drive KA10 6XB Troon Ayrshire | Scotland | British | 124277340001 | |||||
| FRAME, Rosemary | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | Scottish | 267738260001 | |||||
| GRANT, Caelan | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 337549160001 | |||||
| HUNT, Janine Carole | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 195027760001 | |||||
| IMRIE, Margaret Hendry | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 124312700002 | |||||
| JAMIESON, Catherine Mary | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 229907390001 | |||||
| KELLY, Doreen | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 62608990003 | |||||
| LEISHMAN, Ralph Mcilroy | Administrateur | High Tower Lochwinnoch Road PA13 4DU Kilmacolm | Scotland | British | 50032440002 | |||||
| MACDONALD, Marie Elizabeth | Administrateur | Dalziel Drive G41 4PU Glasgow 24 United Kingdom | Scotland | British | 141271720001 | |||||
| MAXTON, Jamie Andrew | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | British | 116263390001 | |||||
| MCDOUGALL, Thomas John | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | Scotland | Scottish | 99513200002 | |||||
| MCINTOSH, Scott Alexander | Administrateur | West Kirk 84a Portland Street KA3 1AA Kilmarnock Ayrshire | United Kingdom | British | 199542810001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PARTNERS FOR INCLUSION ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 27 janv. 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0