SCOTLAND GAS NETWORKS PLC
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTLAND GAS NETWORKS PLC |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
| Numéro de société | SC264065 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| Adresse du siège social | Axis House 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Paul Robert Jeffery en tant que directeur le 01 janv. 2026 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher John Murray en tant qu'administrateur le 01 janv. 2026 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicola Anne Shand en tant que secrétaire le 06 nov. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Statuts | 21 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Anthony John King en tant qu'administrateur le 11 sept. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon David Kilonback en tant qu'administrateur le 11 sept. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2025 | 110 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Afonso Castello-Branco Gois en tant qu'administrateur le 16 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mathew David Turnell-Henry en tant qu'administrateur le 16 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Felipe Ortiz en tant que directeur le 08 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Demes en tant qu'administrateur le 30 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Alexander Adam en tant qu'administrateur le 30 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Fungai Makoni en tant que secrétaire le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Megan Rose Birtwistle en tant que secrétaire le 15 janv. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Herbert Fingerle en tant que directeur le 13 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 107 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Thomazi en tant que directeur le 12 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Antoine Jean René Kerrenneur en tant que directeur le 15 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Jonathan Gross en tant qu'administrateur le 04 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Laura Sandys en tant que directeur le 31 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Megan Rose Birtwistle en tant que secrétaire le 01 nov. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKONI, Fungai | Secrétaire | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 334529540001 | |||||||
| ADAM, James Alexander | Administrateur | 10 Portman Square W1H 6AZ London Ontario Teachers’ Pension Plan (Europe) Limited England | England | British,Canadian | 195244550005 | |||||
| BOTHA, Michael John | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Canada | Canadian | 294271520001 | |||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Administrateur | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||
| CATCHPOLE, Martin Paul | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 285580440001 | |||||
| DEMES, David | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | Slovak | 334083960001 | |||||
| GOIS, Afonso Castello-Branco | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | Portuguese | 335866770001 | |||||
| GROSS, Matthew Jonathan | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United States | American | 318295020001 | |||||
| KILONBACK, Simon David | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 218061760001 | |||||
| KING, Anthony John | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 294251820001 | |||||
| LUMLOCK, Rebecca Elizabeth | Administrateur | One Canada Square, 25th Floor Canary Wharf E14 5AA London Brookfield United Kingdom | United Kingdom | British | 294141090001 | |||||
| MURRAY, Christopher John | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 343967590001 | |||||
| ROSENTHAL, Jeffrey | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Canada | Canadian | 301023190001 | |||||
| SALMON, Nicholas Robin | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 256613430001 | |||||
| SMART, Michael Oswald | Administrateur | 2 St. James's Market SW1Y 4AH London Stepstone Group England | United Kingdom | British | 296382310001 | |||||
| TRIMMER, Paul John Vincent | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 149695050001 | |||||
| TURNELL-HENRY, Mathew David | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | England | British | 335866750001 | |||||
| WHITTINGTON, Joanna Sarah | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | United Kingdom | British | 280100030001 | |||||
| ADAMS, Jonathan Jeffrey | Secrétaire | Station Approach RH6 9HJ Horley St. Lawrence House Surrey | British | 150692050001 | ||||||
| BIRTWISTLE, Megan Rose | Secrétaire | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 315945960001 | |||||||
| DURRANT, Andrew Peter | Secrétaire | 25 Grimwade Close Brantham CO11 1QY Manningtree Essex | British | 85381310003 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Secrétaire | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| GRAY, Ailsa Mary | Secrétaire | 27 Saint Magdalenes Road PH2 0BT Perth | British | 52995340008 | ||||||
| HARDING, Debbie Mary | Secrétaire | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House, 200 | British | 136476220001 | ||||||
| SHAND, Nicola Anne | Secrétaire | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey England | 162700880001 | |||||||
| SYLVESTER, Sharmila Virginia | Secrétaire | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | 290375520001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Administrateur | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Administrateur | 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London The Leadenhall Building United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||
| BUCK, Colin | Administrateur | 8 Northumberland Road CV32 6HA Leamington Spa Warwickshire | England | British | 73844070001 | |||||
| COVASSIN, Tanya Maria | Administrateur | 31 Anderson Avenue M5P 1H5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 103424270002 | ||||||
| DOWD, Stephen Donald | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland Scotland | Ontario, Canada | Canadian | 235050150001 | |||||
| DURRANT, Andrew Peter | Administrateur | 25 Grimwade Close Brantham CO11 1QY Manningtree Essex | British | 85381310003 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Administrateur | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| FAIRBAIRN, Mark Robert | Administrateur | The Old Forge Church Lane Bearley CV37 0SL Stratford Upon Avon | England | British | 187772020001 | |||||
| FINGERLE, Christian Herbert, Dr | Administrateur | 5 Lonehead Drive Newbridge EH28 8TG Edinburgh Axis House Scotland | Germany | German | 193691880001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCOTLAND GAS NETWORKS PLC ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgn Midco Limited | 05 déc. 2017 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sgn Pledgeco Limited | 04 déc. 2017 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Scotia Gas Networks Limited | 06 avr. 2016 | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0