KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED

KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC264587
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Maclay Murray & Spens Quartermile One
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE CAPITAL EAST KILBRIDE LIMITED21 juin 200421 juin 2004
    MOUNTWYND LIMITED08 mars 200408 mars 2004

    Quels sont les derniers comptes de KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 mars 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mars 2011

    État du capital au 24 mars 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mrs Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Susan Groat en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Susan Groat en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2010 au 31 oct. 2010

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de 7 Castle Street Edinburgh Midlothian EH2 3AH le 03 juin 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Gordon Bennet en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    13 pagesAA

    Nomination de Gordon Iain Bennet en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Nomination de Susan Elizabeth Groat en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Wotherspoon en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Mcguinness en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GROAT, Susan Elizabeth
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    ScotlandBritish88980540001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BALL, Nicholas Spencer
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish105270210001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Administrateur
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    United KingdomBritish60009740002
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    GROAT, Susan Elizabeth
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    93
    United Kingdom
    ScotlandBritish88980540001
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritish88980540001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    KERSHAW, Adrian
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    British116630690001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 16 août 2007
    Livré le 25 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 20 juil. 2007
    Livré le 03 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 redwood crescent, red park campus, east kilbride LAN84004 LAN166592 LAN72931.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 2005
    Livré le 15 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Obligations contained in missives dated 14 and 15 september 2004
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 3 redwood crescent, east kilbride, glasgow (title number LAN72931) and the subjects lying to the east of redwwod crescent, east kilbride (title number LAN84004).
    Personnes ayant droit
    • British Energy Generation (UK) LTD.
    Transactions
    • 15 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 2005
    Livré le 11 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 3 redwood crescent, east kilbride, glasgow LAN72931 & subjects lying to east of redwood crescent, east kilbride LAN84004 under exception.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 janv. 2005
    Livré le 07 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all the freehold and leasehold property; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 janv. 2005
    Livré le 07 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    KILMARTIN EAST KILBRIDE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 mars 2012Dissolved on
    31 mars 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0