SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED

SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC267467
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    • (5510) /

    Où se situe SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brodies
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEDS HOTEL GROUP LIMITED24 nov. 200424 nov. 2004
    PACIFIC SHELF 1279 LIMITED06 mai 200406 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 09 nov. 2010

    • Capital: GBP 81
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    8 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolutions

    Repayment approved 28/10/2010
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Repayment approved 28/10/2010
    RES13

    Consolidation des actions au 28 oct. 2010

    5 pagesSH02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    20 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Resignations and appointments approved 28/05/2010
    RES13

    Nomination de Christopher Richard Byrd en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Darren Lyko-Edwards en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Darren Lyko-Edwards en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    20 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BYRD, Christopher Richard
    Blackwell
    CV36 4PE Shipston-On-Stour
    Wisty
    Warwickshire
    Secrétaire
    Blackwell
    CV36 4PE Shipston-On-Stour
    Wisty
    Warwickshire
    British151710020001
    BUDDEN, Christopher David
    Chalet Maria Elise
    Chemin D'Alani 22a
    1936 Verbier
    Case Postale 7
    Switzerland
    Administrateur
    Chalet Maria Elise
    Chemin D'Alani 22a
    1936 Verbier
    Case Postale 7
    Switzerland
    SwitzerlandBritish83251320004
    GRIFFITHS, Keith Ian
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    82 Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish77782610002
    ROBINSON, Shaun
    St. Albans Road
    KT2 5HH Kingston-Upon-Thames
    41
    Surrey
    Administrateur
    St. Albans Road
    KT2 5HH Kingston-Upon-Thames
    41
    Surrey
    United KingdomBritish101627760001
    GRIFFITHS, Keith Ian
    Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    82
    Worcestershire
    Secrétaire
    Greenhill
    WR11 4NH Evesham
    82
    Worcestershire
    British133555690001
    LYKO-EDWARDS, Darren
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    Secrétaire
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    British134551380001
    MCCAFFER, Stuart John
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    Secrétaire
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    British64903230004
    TOWERS, Janet Elizabeth
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    English100644030002
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CAMPBELL, Ewan
    Fullarton Drive
    KA10 6LE Troon
    3
    Ayrshire
    Administrateur
    Fullarton Drive
    KA10 6LE Troon
    3
    Ayrshire
    United KingdomBritish132607650001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish36926690001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish36926690001
    LAPPING, Andrew Christopher
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    Administrateur
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish113467730001
    LYKO-EDWARDS, Darren
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    Administrateur
    Wake Green Road
    Moseley
    B13 9US Birmingham
    113
    West Midlands
    United KingdomBritish134551380001
    MCCAFFER, Stuart John
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    Administrateur
    Bowfell
    52 Peel Road
    G74 5AG Thornton Hall
    Glasgow
    ScotlandBritish64903230004
    ROBINSON, Shaun
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    41 St Albans Road
    KT2 5HH Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish101627760001
    THOMPSON, David George
    14 Grosvenor Crescent
    Dowanhill
    G12 9AF Glasgow
    Administrateur
    14 Grosvenor Crescent
    Dowanhill
    G12 9AF Glasgow
    ScotlandBritish44898070006
    TOWERS, Janet Elizabeth
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Coopers Close
    Bishopton
    CV37 0RS Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandEnglish100644030002
    WOODCOCK, Louis Peter
    Knapdale
    11 East End Road
    PA12 4ER Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Administrateur
    Knapdale
    11 East End Road
    PA12 4ER Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritish39601150001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    SOMERSTON HOTELS (ONE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 31 oct. 2005
    Livré le 17 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charge over express by holiday inn, west M4 junction 16, frankland road, blagrove, swindon WT195205; express by holiday inns at east midlands, hammersmith, luton, cambridge, hemel hempstead, newcastle, bedford, swansea, northa mpton, milton keynes, newport, droitwich spa LT319451 NGL234851 BD225335 BD239124 HD426492 TY417807 BD194553 CYM149465 NN227024 BM252558(excluding BM258115) BM266653 BM281749 BM281748 CYM119834 HW137637 HW176264 WR88756.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 20 déc. 2004
    Livré le 10 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold and leasehold property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0