YOR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéYOR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC268209
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de YOR LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe YOR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    46 Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de YOR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour YOR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    Statuts

    10 pagesMA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 juin 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 20 oct. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge SC2682090008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2682090012 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2682090013 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2682090012 en partie

    1 pagesMR04

    Modification de la charge SC2682090013, créée le 09 mars 2016

    5 pagesMR07

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O a Gray Muir 89 Ravenscroft Street Edinburgh Midlothian EH17 8QS Scotland à 46 Charlotte Square Edinburgh EH2 4HQ

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Andrew Gray Muir en tant que directeur le 30 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Gray Muir en tant que secrétaire le 30 janv. 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Campbell Coombs en tant que secrétaire le 30 janv. 2019

    2 pagesAP03

    Satisfaction de la charge SC2682090011 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de YOR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOMBS, David Campbell
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    Secrétaire
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    254837700001
    MUIR, William John Gray
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    Administrateur
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    ScotlandBritish113700330002
    MUIR, Andrew Gray
    89 Ravenscroft Street
    EH17 8QS Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    89 Ravenscroft Street
    EH17 8QS Edinburgh
    Midlothian
    Scottish154590001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BALL, Nicholas Spencer
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish105270210001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    United Kingdom
    Administrateur
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    United Kingdom
    United KingdomBritish60009740002
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish88980540001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Administrateur
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    MUIR, Andrew Gray
    89 Ravenscroft Street
    EH17 8QS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    89 Ravenscroft Street
    EH17 8QS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandScottish154590001
    STIRLING, Archibald
    Drummerchin
    Kippen
    FK8 3EZ Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    Drummerchin
    Kippen
    FK8 3EZ Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish65368140001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur YOR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr William John Gray Muir
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    16 avr. 2016
    Charlotte Square,
    EH2 4HQ Edinburgh
    46
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    YOR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2017
    Livré le 26 juil. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects at 25, 26 and 27 drumsheugh gardens, edinburgh being those subjects registered in the land register of scotland under title number MID167255.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Welch Group Developments Limited (SC536134)
    Transactions
    • 26 juil. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 mars 2016
    Livré le 11 mars 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    4 miller row, edinburgh otherwise 4 bells brae, edinburgh and 6 & 10 bells brae, edinburgh . see instrument for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Duthus Group Investments Limited
    Transactions
    • 11 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 juil. 2019Détails d'un instrument de modification d'une charge (MR07)
    • 04 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 mars 2016
    Livré le 10 mars 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Part of 4, 6 and 10 bells brae, under exception of (one) the lower ground floor of 4 bell's brae, (two) the east or north-east of 4 bell's brae and (three) rights affecting the middle floor of 4 bells brae. Please refer to instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 10 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mars 2016Détails d'un instrument de modification d'une charge (MR07)
    • 04 sept. 2019Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 27 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 janv. 2016
    Livré le 21 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    25 drumsheugh gardens, edinburgh. 26 drumsheugh gardens edinburgh and 27 drumsheugh gardens.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 21 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 nov. 2014
    Livré le 05 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    23 chester street and 48 manor place edinburgh.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 05 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 nov. 2014
    Livré le 28 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    48 manor place & 23 chester street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • James Mark Keane
    Transactions
    • 28 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 nov. 2014
    Livré le 26 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 26 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 janv. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 01 nov. 2011
    Livré le 14 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects known as and forming croythorn house 23 ravelston terrace edinburgh MID68496 please see form for details.
    Personnes ayant droit
    • Efg Private Bank Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 04 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 01 nov. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Croythorn house 23 ravelston terrace edinburgh MID68496.
    Personnes ayant droit
    • Melfort Properties Limited
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2011
    Livré le 14 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All money, liabilities and obligations due, owing or incurred...see form for further details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Efg Private Bank Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 nov. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2011
    Livré le 31 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Melfort Properties Limited
    Transactions
    • 31 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 11 févr. 2011
    Livré le 11 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 03 nov. 2004
    Livré le 17 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Croythorn house, 23 ravelston terrace, edinburgh MID31813.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 oct. 2004
    Livré le 04 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0