SEASIDE BDL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEASIDE BDL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC268331
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEASIDE BDL LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe SEASIDE BDL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Redpath Bruce Crown House
    152 West Regent Street
    G2 2RQ Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEASIDE BDL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SC268331 LIMITED17 juil. 201817 juil. 2018
    DECKEARTH LIMITED25 mai 200425 mai 2004

    Quels sont les derniers comptes de SEASIDE BDL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SEASIDE BDL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL Scotland à C/O Redpath Bruce Crown House 152 West Regent Street Glasgow G2 2RQ le 02 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 26 nov. 2019

    3 pagesCH01

    Notification de Scarborough Property Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2019

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU Scotland à C/O Shepherd and Wedderburn, 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 04 juil. 2019

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name18 déc. 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de C/O Mazars Llp 90 st. Vincent Street Glasgow G2 5UB à Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU le 01 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2018

    9 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2017

    9 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2015

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2016

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mai 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Kevin Charles Mccabe en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    3 pagesOC-DV

    Certificat de changement de nom

    Company name changed blyth development\certificate issued on 17/07/18
    pagesCERTNM

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Lomond Court Castle Business Park Stirling FK9 4TU à C/O Mazars Llp 90 st. Vincent Street Glasgow G2 5UB le 03 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de SEASIDE BDL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    MCCABE, Kevin Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    England
    EnglandBritish109250000012
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001
    MILTON, William David Martin
    Flat 3/2
    68 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    Secrétaire
    Flat 3/2
    68 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    British98577440001
    MILLER SAMUEL COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Rwf House
    5 Renfield Street
    G2 5EZ Glasgow
    Secrétaire
    Rwf House
    5 Renfield Street
    G2 5EZ Glasgow
    107373400001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    CAIRNDUFF, Kenneth
    19 Kingsborough Gardens
    G12 9NH Glasgow
    Administrateur
    19 Kingsborough Gardens
    G12 9NH Glasgow
    British335620003
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEASIDE BDL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scarborough Property Holdings Limited
    St. John Street
    EC1M 4JN London
    82
    England
    06 avr. 2016
    St. John Street
    EC1M 4JN London
    82
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement4515443
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    SEASIDE BDL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 03 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 03 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 24 mars 2009
    Livré le 03 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as land on the west side of cowpen road, blyth, northumberland known as albion shopping park ND88034 & ND89391.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land on west side of cowpen road, blyth, northumberland known as albion retail park ND88034 ND89391.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 13 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 09 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rents over lease of unit 1, 1A, 2, 2B & 3 albion retail park, cowpen road, blyth.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 09 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 04 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property known as land and buildings on the west side of cowpen road, blyth, blyth valley, northumberland (title numbers ND88034 and ND89391).
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 juil. 2004
    Livré le 10 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SEASIDE BDL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 nov. 2015Commencement of winding up
    20 déc. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0