ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED

ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC269047
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o FRP ADVISORY LLP
    Apex 3 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Ordonnance du tribunal pour dissolution anticipée dans une liquidation par le tribunal

    4 pagesWU16(Scot)

    Cessation de la nomination de Harry James Morgan en tant que directeur le 16 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Rsm Tenon 160 Dundee Street Edinburgh EH11 1DQ* le 12 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    4.9(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 22 Charlotte Square Edinburgh Midlothian EH2 4DF* le 16 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    1 pages4.9(Scot)

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2011

    État du capital au 10 juin 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert William Middleton Brook le 10 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Harry James Morgan le 10 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John David Webber le 10 juin 2011

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Tamar Capital Partners Limited 61 Dublin Street Edinburgh EH3 6NL United Kingdom

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Andrew Mulligan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John David Webber le 10 juin 2010

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Kyle Mulligan le 10 juin 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 05 avr. 2010

    12 pagesAA

    Statuts

    18 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175(5)(a) 10/02/2010
    RES13

    Nomination de Robert William Middleton Brook en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROOK, Robert William Middleton
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    United KingdomBritish149783170001
    WEBBER, John David
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    United KingdomBritish41493670002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secrétaire
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    HEDDERWICK, Alexander Mark
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    Administrateur
    Gifford Bank
    Edinburgh Road
    EH41 4JE Gifford
    East Lothian
    United KingdomBritish89989960001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    MORGAN, Harry James
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Apex 3
    United KingdomBritish103806200002
    MORRIS, Philip Taylor
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Oxford Terrace
    EH4 1PX Edinburgh
    Scotland
    British35386590001
    MULLIGAN, Andrew Kyle
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    186 Cockburn Crescent
    Balerno
    EH14 7LU Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish161603300002
    ROBSON, Ronald Alexander
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    19 Glasclune Gardens
    EH39 4RB North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish104673590001

    ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental security agreement
    Créé le 17 juil. 2006
    Livré le 27 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage land and buildings at thynne street, bolton LA163070.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag
    Transactions
    • 27 juil. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 31 mai 2006
    Livré le 05 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold land and buildings at llantrisant, pontyclun CYM74964.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag
    Transactions
    • 05 juin 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 2006
    Livré le 25 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The leasehold interest in the subjects at blair court, clydebank business park, clydebank dmb 78012.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag, London Branch
    Transactions
    • 25 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 11 avr. 2006
    Livré le 21 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as blair court, clydebank business park, clydebank dmb 78012.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag
    Transactions
    • 21 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 11 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of a first legal mortgage all estates and interests in the property specified in the schedule to the deed.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag
    Transactions
    • 11 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 07 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over leasehold property known as units a & b, seaham grange industrial estate, seaham, durham.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International Ag
    Transactions
    • 07 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 déc. 2005
    Livré le 21 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1,2,3,4A,4B,4C,4D,4E,4F & 11 forties campus & unit 16, cromarty campus, rosyth europarc FFE23924.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 21 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 09 déc. 2005
    Livré le 14 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the rental income over units 1,2,3,4A,4B,4C,4D,4E,4F & 11 forties campus & unit 16 cromarty campuse, rosyth europarc FFE23924.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 14 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 18 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold property on north east side of darby close, cheney manor industrial estate, swindon, wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 19 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over tenon house, ferryboat lane, sunderland TY384699.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 14 juil. 2005
    Livré le 19 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tenants interest under the three leases of the property known as 636-646 south street, glasgow between the city of glasgow district council and havelock builders limited gla 14907.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 19 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 04 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    Right, title and interest in and to the rental income in respect of the property known as 636-646 south street, glasgow (title number GLA14907).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 juin 2005
    Livré le 12 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as 3 to 10 callander business park in the county of stirling.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 12 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 29 juin 2005
    Livré le 08 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The assignor assigns all right, title and interest in and to the rental income as security for the secured liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 08 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to a credit agreement dated 2 march 2005 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 870/890 south street, whiteinch, glasgow (title number GLA71872).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to a credit agreement dated 2 march 2005 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brèves mentions
    The subjects on the northeast side of craigmont street, maryhill, glasgow (sometime known as 24 craigmont street, glasgow) (title number GLA80152).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or puruant to a credit agreement dated 2 march 2005 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 23 cliftonhall road, newbridge, edinburgh (title number MID12530).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to a credit agreement dated 2 march 2005 and each finance document referred to as such in the credit agreement
    Brèves mentions
    The subjects on the northeast side of south street, glasgow known as albion trading estate (title number GLA33429).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 mars 2005
    Livré le 29 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the rental income in relation to the subjects known as and forming 870/890 south street, whiteinch, glasgow (title number GLA71872).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 29 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 mars 2005
    Livré le 29 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the rental income in relation to the subjects known as and forming 23 cliftonhall road, newbridge, edinburgh (title number MID12530).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 29 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 mars 2005
    Livré le 29 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the rental income in relation to the subjects on the northeast side of craigmont street, maryhill, glasgow (sometime known as 24 craigmont street, glasgow) (title number GLA80152).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 29 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 mars 2005
    Livré le 29 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the credit agreement and each finance document
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the rental income in relation to the subjects on the northeast side of south street, glasgow known as albion trading estate (title number GLA33429).
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International
    Transactions
    • 29 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Supplemental security agreement
    Créé le 15 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold or leasehold property being: 3 horseshoes mall, warminster, wiltshire WT110331 WT101109 WT179676.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International as Agen and Trustee
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Security agreement
    Créé le 02 mars 2005
    Livré le 14 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over real property. Firts fixed charge over shares, all plant and machinery. See form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International as Agent & Trustee
    Transactions
    • 14 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)

    ADAM & COMPANY SECOND GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2012Conclusion of winding up
    14 déc. 2011Petition date
    14 déc. 2011Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Thomas Cambpell Maclennan
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    provisional liquidator
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    Kenneth Robert Craig
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    provisional liquidator
    48 St. Vincent Street
    G2 5TS Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    17 août 2020Conclusion of winding up
    31 janv. 2012Petition date
    31 janv. 2012Commencement of winding up
    17 déc. 2020Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kenneth Robert Craig
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    practitioner
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Thomas Campbell Maclennan
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    practitioner
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0