CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT

CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC270425
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    • Activités d'autres organisations membres n.c.a. (94990) / Autres activités de services

    Où se situe CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    Adresse du siège social
    C/O University Of The West Of Scotland Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 oct. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juil. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 juil. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2024

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2023

    5 pagesAA

    Nomination de Mrs Claire Young en tant qu'administrateur le 26 févr. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Johnny Mone en tant que directeur le 26 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2022

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Gordon Hugh Morison en tant qu'administrateur le 09 janv. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Dominic Paul Elliott en tant que directeur le 31 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Babcock International Group Kintail House 3 Lister Way Hamilton International Business Park Blantyre Glasgow G72 0FT à C/O University of the West of Scotland Technology Avenue Blantyre Glasgow G72 0LH le 02 déc. 2021

    1 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2020

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Dominic Paul Elliott en tant qu'administrateur le 09 août 2021

    2 pagesAP01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2020 au 30 oct. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sally Fiona Brooks en tant que directeur le 05 mars 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Grant Sinclair en tant que directeur le 09 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Sally Fiona Brooks en tant qu'administrateur le 04 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pieter Esbach en tant que directeur le 05 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ehsan Mesbahi en tant que directeur le 04 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 oct. 2018

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CUCKOW, Emma Louise
    c/o University Of The West Of Scotland
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    High Street
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    c/o University Of The West Of Scotland
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    High Street
    Renfrewshire
    Scotland
    195536080001
    MCINNES, Gordon Andrew
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish241905030001
    MORISON, Gordon Hugh
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish303996550001
    PACITTI, Giuseppe Luigi
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish171274870001
    PEARSON, David Forbes
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish157136740001
    ROBERTSON, Craig Byron
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish241758120001
    STEWART, Karen
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish260052850001
    YOUNG, Claire
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandScottish186383790001
    BISHOP, Ian
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    157045290001
    MCLELLAND, Brian
    44 Amochrie Glen
    PA2 0DY Paisley
    Secrétaire
    44 Amochrie Glen
    PA2 0DY Paisley
    British104718070001
    ROACH, Alan Colin
    93 Octavia Terrace
    PA16 7PY Greenock
    Renfrewshire
    Secrétaire
    93 Octavia Terrace
    PA16 7PY Greenock
    Renfrewshire
    British90230920001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    ALLISON, Ian Kevin
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish200286410001
    BICKERSTAFF, Gordon Fergusson
    9 Springfield Park
    PA5 8JS Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    9 Springfield Park
    PA5 8JS Johnstone
    Renfrewshire
    British98929640001
    BISHOP, Ian
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish114430580002
    BROOKS, Sally Fiona
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    ScotlandBritish249268060001
    DILLON, Peter David
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    ScotlandBritish200288900001
    DODD, Ian Rees
    5 Kirklands Drive
    Newton Mearns
    G77 5FF Glasgow
    Administrateur
    5 Kirklands Drive
    Newton Mearns
    G77 5FF Glasgow
    ScotlandBritish37550740002
    DUFFY, Gordon Joseph
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish122114200001
    DYMOND, Lorraine
    Raillies Avenue
    KA30 8QY Largs
    23
    Scotland
    Administrateur
    Raillies Avenue
    KA30 8QY Largs
    23
    Scotland
    British153477960001
    ELLIOTT, Dominic Paul
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Technology Avenue
    Blantyre
    G72 0LH Glasgow
    C/O University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish286105370001
    ESBACH, Pieter
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    EnglandBritish174765630001
    FOSTER, Monika, Professor
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    ScotlandBritish250989690001
    FOTHERINGHAM, Stephen Thomas
    26 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    Administrateur
    26 Milverton Road
    Giffnock
    G46 7JN Glasgow
    ScotlandBritish60214790002
    GOLDIE, Craig Steven
    Netherby
    188 Eastwoodmains Road
    G76 7HA Glasgow
    Administrateur
    Netherby
    188 Eastwoodmains Road
    G76 7HA Glasgow
    British109641080001
    HARROLD, James
    5 Dalkeith Avenue
    G41 5BH Glasgow
    Administrateur
    5 Dalkeith Avenue
    G41 5BH Glasgow
    British111756820001
    MCCARTHY, Gerard John
    7 Swallow Brae
    PA16 0LF Inverkip
    Renfrewshire
    Administrateur
    7 Swallow Brae
    PA16 0LF Inverkip
    Renfrewshire
    ScotlandBritish76685410001
    MCDOUGALL, John
    Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    85
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    85
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish133188720001
    MCLELLAND, Brian
    44 Amochrie Glen
    PA2 0DY Paisley
    Administrateur
    44 Amochrie Glen
    PA2 0DY Paisley
    ScotlandBritish104718070001
    MESBAHI, Ehsan
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish215485690001
    MONE, Johnny
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    PA1 2BE Paisley
    University Of The West Of Scotland
    Renfrewshire
    Scotland
    United KingdomBritish166343710003
    MOY, Gerard
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    c/o Babcock International Group
    3 Lister Way
    Hamilton International Business Park
    G72 0FT Blantyre
    Kintail House
    Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish104467880001
    MOY, Gerard
    15 Upper Bridge Street
    G83 0AR Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    15 Upper Bridge Street
    G83 0AR Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish104467880001
    NEIL, George Colin Currie
    26 Glasgow Road
    KA3 1TL Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    26 Glasgow Road
    KA3 1TL Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish98911230001
    POLONIS, Ian William
    149 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Scotland
    Administrateur
    149 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Scotland
    ScotlandBritish77610480001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION & DEVELOPMENT ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0