HYMORE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHYMORE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC271129
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HYMORE LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe HYMORE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    ERNST & YOUNG LLP
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HYMORE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE HYDON ONE LIMITED04 mars 200504 mars 2005
    DMWS 683 LIMITED26 juil. 200426 juil. 2004

    Quels sont les derniers comptes de HYMORE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour HYMORE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    6 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    16 pages2.15B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    6 pages2.20B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    21 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Agreement 08/02/08
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sub-divide 08/02/08
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Résolutions

    Resolutions
    13 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages122

    Qui sont les dirigeants de HYMORE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Anne Elizabeth
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    Secrétaire
    Ramsay Crescent
    Mayfield
    EH22 5RA Dalkeith
    13
    Midlothian
    British74781620001
    MEGAN, Michael Francis
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    Administrateur
    Highlands
    RG14 6NZ Newbury
    8
    Berkshire
    EnglandIrish46067860003
    REID, Andrew Richard
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Summerfield Road
    Cumbernauld
    G67 4PA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish145630001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    THOMSON, William George Ritchie
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    Administrateur
    The Old House Of Orchill
    FK15 9LF Braco
    Perthshire
    ScotlandBritish72331280002
    WADSWORTH, Timothy Murray
    Dowlands House
    Rousdon
    DT7 3XP Lyme Regis
    Administrateur
    Dowlands House
    Rousdon
    DT7 3XP Lyme Regis
    United KingdomBritish34037140009
    WILKINSON, Charles George
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    Gilbury
    30 Riverside Road West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritish47095110003
    DM DIRECTOR LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900020020001

    HYMORE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 2006
    Livré le 18 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 and ST199157 includes fixed and floating charges.
    Personnes ayant droit
    • Lochay Investments Limited
    Transactions
    • 18 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 2006
    Livré le 18 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 and ST199157 includes fixed and floating charges.
    Personnes ayant droit
    • Kenmore Investments Limited
    Transactions
    • 18 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tonedale mill, wellington, somerset ST1516 ST200245 ST247441 ST199157.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 03 oct. 2006
    Livré le 10 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 oct. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 2005
    Livré le 21 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of a legal mortgage over freehold land at and buildings known as 73 north street, crewkerne WS3601 land on the north east side of north street, crewkerne, somerset ws 28865 all that land and building known as old brewery barn north street, crewkerne WS3601 and ws 28865.
    Personnes ayant droit
    • Lochay Investments Limited
    Transactions
    • 21 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 2005
    Livré le 21 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of a legal mortgage over freehold land at and buildings known as 73 north street, crewkerne WS3601 land on the north east side of north street, crewkerne, somerset ws 28865 all that land and building known as old brewery barn north street, crewkerne WS3601 and ws 28865.
    Personnes ayant droit
    • Kenmore Investments Limited
    Transactions
    • 21 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 2005
    Livré le 12 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on the north east side of north street, crewkerne, somerset (title number WS28865) and old brewery barn, north street, crewkerne, somerset.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold land and buildings at 73 north street, crawkerne WS3601.
    Personnes ayant droit
    • Lochay Investments Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold land and buildings at 73 north street, crawkerne WS3601.
    Personnes ayant droit
    • Kenmore Investments Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2005
    Livré le 21 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 mars 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 avr. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2005
    Livré le 21 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The freehold property known as 73 north street, crewkerne, somerset (title number WS3601).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)

    HYMORE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 nov. 2012Administration ended
    12 déc. 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0