DUNBIA AYR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNBIA AYR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC274213
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNBIA AYR LIMITED ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe DUNBIA AYR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    Ayrshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNBIA AYR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LYNCH QUALITY MEATS (AYRSHIRE) LIMITED20 juin 200520 juin 2005
    BRASTON QUALITY MEATS LTD.05 oct. 200405 oct. 2004

    Quels sont les derniers comptes de DUNBIA AYR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNBIA AYR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Satisfaction de la charge SC2742130010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2742130011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2742130012 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2742130008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC2742130009 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Matthew Samuel Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James George Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Dunbia (Uk) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    4 pagesPSC02

    État du capital au 11 déc. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de Dunbia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    3 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2018

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sean Breen en tant que secrétaire le 27 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Inscription de la charge SC2742130012, créée le 10 janv. 2018

    43 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de DUNBIA AYR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish223137440001
    QUEALY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239255100002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Secrétaire
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239272930001
    LYNCH, John Stevenson
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Scotland
    Secrétaire
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Scotland
    British94098720002
    PICKLES, Andrew John
    1 Chapelpark Road
    KA7 2TZ Ayr
    Secrétaire
    1 Chapelpark Road
    KA7 2TZ Ayr
    British70067030004
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Administrateur
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    United KingdomBritish130963600004
    DOBSON, James George
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Administrateur
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Northern IrelandBritish60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Administrateur
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Northern IrelandBritish216974160001
    DOBSON, Robert John
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Administrateur
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Northern IrelandBritish60768390001
    LYNCH, John Stevenson
    Laigh Grange
    KA19 8EF Maybole
    Holmes
    Ayrshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Laigh Grange
    KA19 8EF Maybole
    Holmes
    Ayrshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish5960003
    LYNCH, William Nixon
    East Brock Loch Farm
    KA19 8DG Maybole
    Ayrshire
    Administrateur
    East Brock Loch Farm
    KA19 8DG Maybole
    Ayrshire
    ScotlandBritish108504650001
    LYNCH JNR, John Stevenson
    Brae Of Auchendrane
    KA7 4TB Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    Brae Of Auchendrane
    KA7 4TB Ayr
    Ayrshire
    ScotlandBritish94098720001
    PICKLES, Andrew John
    1 Chapelpark Road
    KA7 2TZ Ayr
    Administrateur
    1 Chapelpark Road
    KA7 2TZ Ayr
    ScotlandBritish70067030004
    POTTS, Colin Edwin
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    Administrateur
    Littlemill Road
    Drongan
    KA6 7BP Ayr
    1
    Ayrshire
    United KingdomBritish125726160003
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUNBIA AYR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    29 nov. 2019
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    Non
    Forme juridiqueUnlimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03382084
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House United Kingdom
    Numéro d'enregistrementNi059523
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DUNBIA AYR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 janv. 2018
    Livré le 18 janv. 2018
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 janv. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 janv. 2018
    Livré le 18 janv. 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 18 janv. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 déc. 2017
    Livré le 29 déc. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 29 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 oct. 2017
    Livré le 27 oct. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects on the southeast side of mill of shield road, drongan, ayr being the subjects registered in the land register of scotland under title number AYR14463.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 27 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 16 oct. 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 16 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 juil. 2014
    Livré le 01 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 01 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2014
    Livré le 12 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 20 nov. 2008
    Livré le 29 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on southeast side of mill of shield road, drongan, ayr AYR14463.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 26 août 2008
    Livré le 30 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 30 août 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 04 oct. 2006
    Livré le 18 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects lying on the south east side of mill o'shield road, drongan and at littlemill road, drongan AYR14463.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 08 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 08 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 févr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 juin 2006
    Livré le 28 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 juin 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 févr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0