REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREFUGEE SANCTUARY SCOTLAND
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC274440
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    • Activités d'autres organisations membres n.c.a. (94990) / Autres activités de services

    Où se situe REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Adresse du siège social
    Floor 3, Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REFUGEE SURVIVAL TRUST09 oct. 200409 oct. 2004

    Quels sont les derniers comptes de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 oct. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 oct. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ronald Tapiwa Hlabanai Tagwireyi en tant que directeur le 02 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Amy Westendarp en tant que directeur le 15 janv. 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024

    27 pagesAA

    Nomination de Mr Derek George May en tant qu'administrateur le 07 févr. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ajmal Yamin en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    34 pagesAA

    Nomination de Mr Milan Copic en tant qu'administrateur le 10 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Elizabeth-Mya Chemonges-Murzynowska en tant qu'administrateur le 09 oct. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mary Agatha Kai-Kai en tant que directeur le 04 oct. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Monojit Chatterji en tant que directeur le 04 oct. 2023

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Amy Westendarp le 30 mai 2023

    2 pagesCH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed refugee survival trust\certificate issued on 05/07/23
    4 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name05 juil. 2023

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Statuts

    17 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Katrina Jane Wilson en tant que directeur le 13 juin 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Ashley Fleming en tant qu'administrateur le 15 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mahindhan Nadanasabapathy en tant qu'administrateur le 03 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mahindhan Nadanasabapathy en tant que directeur le 01 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    36 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHEMONGES-MURZYNOWSKA, Elizabeth-Mya
    Station Drive
    Ardersier
    IV2 7RD Inverness
    7
    Scotland
    Administrateur
    Station Drive
    Ardersier
    IV2 7RD Inverness
    7
    Scotland
    ScotlandKenyan314513690001
    COPIC, Milan
    Park Road
    AB24 5RZ Aberdeen
    130 Oceon Apartments, 52-54
    Scotland
    Administrateur
    Park Road
    AB24 5RZ Aberdeen
    130 Oceon Apartments, 52-54
    Scotland
    ScotlandBritish314514110001
    FINER, Emily, Dr
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish287984200001
    FLEMING, Ashley
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    United KingdomBritish309578310001
    MAY, Derek George
    Manse Road
    ML1 2PY Motherwell
    142
    United Kingdom
    Administrateur
    Manse Road
    ML1 2PY Motherwell
    142
    United Kingdom
    ScotlandBritish149925790001
    NADANASABAPATHY, Mahindhan
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish227096970001
    BROOKS, Kerrie
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    179212800001
    MCILWHAN, Rosemarie
    5 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    Secrétaire
    5 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    British168328830001
    PRICE, Janet Elisabeth
    26/2 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    26/2 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    British100652790001
    ROSS, Duncan Fraser
    132 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    132 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    British108237430001
    ALEXANDER, Catherine
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritish189203520001
    ALSABAN, Abdulbaset Abdulwasea Ali
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandYemeni258236130001
    BAVENDALE, Eileen Janet Gladys
    Larchfield Drive
    Rutherglen
    G73 4HA Glasgow
    1
    South Lanarkshire
    Administrateur
    Larchfield Drive
    Rutherglen
    G73 4HA Glasgow
    1
    South Lanarkshire
    ScotandBritish137652350001
    BEALE, Anna
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish179212860001
    BECK, James
    Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Refugee Survival Trust
    Scotland
    Administrateur
    Robertson House
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Refugee Survival Trust
    Scotland
    ScotlandBritish251795270001
    BOLES, Christopher, Rev
    28 Lauriston Street
    EH3 9DJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    28 Lauriston Street
    EH3 9DJ Edinburgh
    Midlothian
    British100652780001
    BONELLA, Philippa Mary
    Glengyle Terrace
    EH3 9LL Edinburgh
    8a
    Midlothian
    Administrateur
    Glengyle Terrace
    EH3 9LL Edinburgh
    8a
    Midlothian
    United KingdomBritish153891340001
    BROCK, Jacqueline Elisabeth
    38 Marlborough Street
    EH15 2BG Edinburgh
    Administrateur
    38 Marlborough Street
    EH15 2BG Edinburgh
    ScotlandBritish281233310001
    BROOKS, Kerrie Rebecca Taylor
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish168221020002
    BUJANDA-VALIENTE, Vladimir
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandBritish179212870001
    CHATTERJI, Monojit, Professor
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish258431010001
    CONBOY, Barbara Beryl
    71 Charterhall Grove
    EH9 3HT Edinburgh
    Administrateur
    71 Charterhall Grove
    EH9 3HT Edinburgh
    ScotlandBritish43572590001
    CRICHTON, Judith Anne
    15 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    Administrateur
    15 Rose Street
    EH2 2PR Edinburgh
    The Melting Pot
    Scotland
    ScotlandBritish112791730001
    FARMER, Jacqueline Clare Margaret
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritish203163750001
    FARRIER, David Christopher, Dr
    Orchard Brae Gardens
    EH4 2HH Edinburgh
    62
    U.K.
    Administrateur
    Orchard Brae Gardens
    EH4 2HH Edinburgh
    62
    U.K.
    U.K.British168220900001
    GARDINER, Angela
    13 Parkgrove Terrace
    G3 7SD Glasgow
    2/2
    Uk
    Administrateur
    13 Parkgrove Terrace
    G3 7SD Glasgow
    2/2
    Uk
    UkBritish108117570001
    GILLESPIE, Morag Helen
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritish202253820001
    GOLDSMITH, Marion Hilda
    82 Woodfield Park
    EH13 0RB Edinburgh
    Administrateur
    82 Woodfield Park
    EH13 0RB Edinburgh
    British100652760002
    GOODWIN, Karin
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandBritish202323080001
    GREEN, Mhoraig
    12 Grantley Gardens
    G41 3QA Glasgow
    1/2
    Scotland
    Administrateur
    12 Grantley Gardens
    G41 3QA Glasgow
    1/2
    Scotland
    ScotlandBritish137652110002
    IBRAHIM, Adnan
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    Administrateur
    Stanhope House
    Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Suite B
    Midlothian
    ScotlandIraqi229945190001
    KAI-KAI, Mary Agatha, Dr
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Floor 3, Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish203163380001
    KAIFALA, Gabriel Bamie, Dr
    South Portland Street
    G9 5JL Glasgow
    37
    Lanarkshire
    Uk
    Administrateur
    South Portland Street
    G9 5JL Glasgow
    37
    Lanarkshire
    Uk
    ScotlandBritish173541580001
    LOGAN, Alan David Keith
    EH51 9RP By Bo'Ness
    Old Kinglass Farmhouse
    West Lothian
    Administrateur
    EH51 9RP By Bo'Ness
    Old Kinglass Farmhouse
    West Lothian
    British130440110001
    LYLE, Kaliani
    Nile Grove
    EH10 4RE Edinburgh
    19
    Midlothian
    Administrateur
    Nile Grove
    EH10 4RE Edinburgh
    19
    Midlothian
    ScotlandBritish272210001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour REFUGEE SANCTUARY SCOTLAND ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    10 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0