SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC277788
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CREDENTIAL PROPERTY MANAGEMENT LIMITED04 févr. 200504 févr. 2005
    MM&S (4044) LIMITED23 déc. 200423 déc. 2004

    Quels sont les derniers comptes de SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 janv. 2014

    État du capital au 25 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ronald Barrie Clapham le 23 déc. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Venlaw Building 349 Bath Street Glasgow G2 4AA* le 03 mai 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    11 pagesAA

    legacy

    9 pagesMG01s

    Modifications à la charge flottante 11

    21 pages466(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    41 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Sect 175/conflict of interests 27/05/2011
    RES13

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed credential property management LIMITED\certificate issued on 08/04/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    08 avr. 2010

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Douglas Alexander Cumine le 23 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Derek Porter le 23 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ronald Barrie Clapham le 23 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CUMINE, Douglas Alexander
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    BritishChartered Accountant85590510001
    CLAPHAM, Ronald Barrie
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector101562830001
    CUMINE, Douglas Alexander
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    ScotlandBritishChartered Accountant85590510001
    PORTER, Derek
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Elmbank Gardens
    G2 4NQ Glasgow
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant47585310001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    BritishChartered Accountant47585310001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    SQUEEZE NEWCO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Assignment of rents
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rights, titles, benefits, and interests, whether present or future, of the company in and to the rents over land on the south west of southwood drain, breighton, yorkshire HS246276.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment of rents
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rights, titles, benefits, and interests, whether present or future, of the company in and to the rents over land on the south west of watling street, stretton, baskerville LT320301.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 10 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under each of the composite finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 10 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the composite finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the freehold land on the south west side of southwood drain, breighton, yorkshire (title number HS246276).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 10 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the composite finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the freehold land on the south west of watling street, stretton, baskerville (title number LT320301).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 17 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 14 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as land on south west side of southwood drain, breighton HS246276.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 14 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as land lying to south-west of watling street, stretton, baskerville LT320301.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mars 2005
    Livré le 14 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as the land and buildings on east side of stevenson road, sheffield SYK417126.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0