ENABLE SCOTLAND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENABLE SCOTLAND
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC278976
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENABLE SCOTLAND ?

    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe ENABLE SCOTLAND ?

    Adresse du siège social
    Inspire House 3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENABLE SCOTLAND ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENABLE SCOTLAND (2005)27 janv. 200527 janv. 2005

    Quels sont les derniers comptes de ENABLE SCOTLAND ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ENABLE SCOTLAND ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 janv. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation10 févr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au27 janv. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour ENABLE SCOTLAND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Katie Maree Morrison en tant que directeur le 31 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2025

    51 pagesAA

    Nomination de Professor Andrea Mary Nolan en tant qu'administrateur le 02 juin 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Clare Flynn en tant qu'administrateur le 23 mai 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Professor James Crowe Curran en tant qu'administrateur le 23 mai 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2024

    47 pagesAA

    Nomination de Mrs Pooja Mihir Joglekar en tant qu'administrateur le 27 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Andrew Booth en tant que directeur le 20 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Statuts

    36 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Thomas Glen en tant qu'administrateur le 24 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Jukes en tant que directeur le 18 juin 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Margaret Rose Harkins en tant qu'administrateur le 31 mai 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Professor Eleanor Shaw Obe en tant qu'administrateur le 31 mai 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2023

    47 pagesAA

    Nomination de Mr Alan Davidson Mcqueen en tant que secrétaire le 01 nov. 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Mhairi Frances Maguire en tant que secrétaire le 31 oct. 2023

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de John Roderick Brady en tant que directeur le 26 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kenneth James Pinkerton en tant que directeur le 31 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2022

    50 pagesAA

    Cessation de la nomination de David John Hillier en tant que directeur le 16 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ENABLE SCOTLAND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCQUEEN, Alan Davidson
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Secrétaire
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    315627880001
    CURRAN, James Crowe, Professor
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish336157180001
    FLYNN, Clare
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish295631250001
    GAULT, Shareen Bibi
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish283409780001
    GLEN, Thomas
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish140550660002
    HARKINS, Margaret Rose
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomIrish292365390001
    JOGLEKAR, Pooja Mihir
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish283499550001
    MCELROY, Anthony James
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish168265920001
    MCMAHON, Paul Dominic
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish141539050002
    MEEK, Alan Crawford
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish155230850001
    MORRISON, Elizabeth Isabella
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish267913630001
    NOLAN, Andrea Mary, Professor
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandIrish101259790001
    SHAW OBE, Eleanor, Professor
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    United KingdomBritish303535820001
    ANDREW, Chris
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Secrétaire
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    197083200001
    DUNNING, Norman Moore
    7 The Ness
    FK14 7EB Dollar
    Clackmannanshire
    Secrétaire
    7 The Ness
    FK14 7EB Dollar
    Clackmannanshire
    British4655000001
    MAGUIRE, Mhairi Frances
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Secrétaire
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    200831320001
    SCOTT, Peter Edgar
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    Secrétaire
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    149477250001
    TC YOUNG
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Secrétaire désigné
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    900026150001
    ARMSTRONG, Josephine
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    ScotlandBritish121182240002
    BARRACLOUGH, David Rex
    49 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    Administrateur
    49 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    ScotlandBritish78047190001
    BERUWIEN, Rassmi, Dr
    Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    49
    City Of Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    49
    City Of Edinburgh
    Scotland
    ScotlandBritish135182310002
    BOOTH, Martin Andrew
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish260169930001
    BOYLE, Marcella Frances
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    ScotlandBritish164519360001
    BRADLEY, Amanda Jane
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish187222030001
    BRADY, John Roderick
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish112416760001
    BROWN, Brian
    1 Wellwood Square
    Pennyburn
    KA13 6NG Kilwinning
    Ayrshire
    Administrateur
    1 Wellwood Square
    Pennyburn
    KA13 6NG Kilwinning
    Ayrshire
    ScotlandBritish111955860001
    CAMPBELL, Calum
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish187222120001
    CHARTERS, Andrew David
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish78872100002
    CHLEBOWSKA, Jean
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish189610050001
    CHRISTIE, Patricia Mary
    Hollybank
    Biggar Road
    ML11 8HJ Carnwath
    South Lanarkshire
    Administrateur
    Hollybank
    Biggar Road
    ML11 8HJ Carnwath
    South Lanarkshire
    British63983060002
    COLLETT, John Edward
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    ScotlandBritish36850350001
    COULL, Andrew
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    ScotlandBritish136349520001
    COWIE, Robert
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    Administrateur
    3 Renshaw Place
    Eurocentral
    ML1 4UF Lanarkshire
    Inspire House
    Scotland
    ScotlandBritish164519380001
    EWING, Mark Espie
    Baldernock Glebe
    Baldernock, Milngavie
    G62 6HA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Baldernock Glebe
    Baldernock, Milngavie
    G62 6HA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandScottish66920100001
    FERGUSON, Wendy Ann
    House
    Longnewton Farm House By Gifford
    EH41 4JW By Gifford
    Longnewton Farm
    East Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Longnewton Farm House By Gifford
    EH41 4JW By Gifford
    Longnewton Farm
    East Lothian
    United Kingdom
    ScotlandUnited Kingdom96233810002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ENABLE SCOTLAND ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    27 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0